the royal gazette / gazette royale (11/06/29) · 9 an act to amend the crown lands and forests act...
TRANSCRIPT
The RoyalGazette
FrederictonNew Brunswick
Gazetteroyale
FrederictonNouveau-Brunswick
Vol. 169 Wednesday, June 29, 2011 / Le mercredi 29 juin 2011 755
ISSN 1714-9428
Notice to Readers
The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.
PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2011-171, I declare that section 1,paragraph 7(b), sections 8 and 11 and section 13 as it relates toparagraph (d.3) of An Act to Amend the Family Services Act,Chapter 8 of the Acts of New Brunswick, 2010, come into forceJune 13, 2011.
This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on June 9,2011.
Marie-Claude Blais, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor
Proclamations
Avis aux lecteurs
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.
PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2011-171, je déclare le13 juin 2011 date d’entrée en vigueur de l’article 1, de l’alinéa7b), des articles 8 et 11 et de l’article 13 se rapportant à l’alinéad.3) de la Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, cha-pitre 8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010.
La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 9 juin 2011.
Le procureur général, Le lieutenant-gouverneur,Marie-Claude Blais, c.r. Graydon Nicholas
Proclamations
The Royal Gazette — June 29, 2011 756 Gazette royale — 29 juin 2011
ACTS PASSED IN 2011DURING THE 1st SESSION OF
THE 57th LEGISLATURE
Chap.
Royal Assent: April 1, 2011
Title1 An Act to Dissolve the Saint John Harbour Bridge
Authority
Chap.
Royal Assent: May 11, 2011
Title2 An Act to Amend An Act to Amend the Motor
Vehicle Act
Chap.
Royal Assent: June 10, 2011
Title3 An Act to Amend the Assessment Act4 An Act to Amend An Act Respecting Building
Officials and the New Brunswick Building Officials Association
5 An Act to Amend An Act to Amend the Pension Benefits Act
6 An Act to Amend the Police Act7 An Act to Amend the Scalers Act8 An Act to Amend the Forest Products Act9 An Act to Amend the Crown Lands and Forests
Act10 An Act to Amend the Fish and Wildlife Act11 An Act to Amend the Public Interest Disclosure
Act12 An Act Respecting Provincial Court Judges’
Pensions13 An Act to Amend the Land Titles Act14 An Act to Amend the Transportation of Primary
Forest Products Act15 An Act to Amend the Provincial Court Act16 An Act to Amend the Provincial Offences
Procedure Act17 An Act to Amend the Limitation of Actions Act18 An Act to Amend the Shortline Railways Act
19 An Act to Amend the Interpretation Act20 An Act Respecting the Revised Statutes, 201121 An Act to Amend the Municipalities Act22 An Act to Amend the Fire Prevention Act23 Referendum Act24 Invest New Brunswick Act25 An Act to Amend the Municipal Elections Act26 An Act Respecting Midwives27 An Act to Amend the Prescription Drug Payment
Act28 An Act to Amend the Family Services Act29 An Act to Amend the Essential Services in
Nursing Homes Act
Notices
LOIS ADOPTÉES EN 2011AU COURS DE LA 1re SESSION DE LA
57e LÉGISLATURE
Sanction royale : le 1er avril 2011
Titre
BillProjetde loi
Loi prévoyant la dissolution du Saint John Harbour Bridge Authority
14
Sanction royale : le 11 mai 2011
Titre
BillProjetde loi
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
24
Sanction royale : le 10 juin 2011
Titre
BillProjetde loi
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation 6Loi modifiant la Loi concernant les officiels de la
construction et l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick
15
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
16
Loi modifiant la Loi sur la police 17Loi modifiant la Loi sur les mesureurs 18Loi modifiant la Loi sur les produits forestiers 19Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts
de la Couronne20
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune 21Loi modifiant la Loi sur les divulgations faites dans
l’intérêt public22
Loi concernant les pensions des juges de la Cour provinciale
23
Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement foncier 25Loi modifiant la Loi sur le transport des produits
forestiers de base26
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale 27Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales28
Loi modifiant la Loi sur la prescription 29Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer de courtes
lignes30
Loi modifiant la Loi d’interprétation 31Loi concernant les Lois révisées de 2011 32Loi modifiant la Loi sur les municipalités 33Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies 34Loi référendaire 35Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick 36Loi modifiant la Loi sur les élections municipales 37Loi relative aux sages-femmes 38Loi modifiant la Loi sur la gratuité des médicaments sur
ordonnance39
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille 40Loi modifiant la Loi sur les services essentiels dans les
foyers de soins41
Avis
The Royal Gazette — June 29, 2011 757 Gazette royale — 29 juin 2011
30 An Act to Amend the Municipalities Act31 An Act to Amend the Crown Lands and Forests
Act32 An Act to Amend the Regional Health Authorities
Act33 An Act to Amend the Pension Benefits Act34 An Act to Amend the Legislative Assembly Act35 An Act Respecting Members’ Pensions36 An Act Respecting Expenditure Restraint37 An Act Respecting Vital Statistics38 An Act to Amend the Tobacco Tax Act39 An Act to Amend the Gasoline and Motive Fuel
Tax Act40 An Act to Amend the New Brunswick Income
Tax Act41 Loan Act 201142 Appropriations Act 2011-2012
Loi modifiant la Loi sur les municipalités 42Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts
de la Couronne44
Loi modifiant la Loi sur les régies régionalesde la santé
45
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension 46Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative 47Loi concernant les pensions des députés 48Loi concernant la compression des dépenses 49Loi concernant les statistiques de l’état civil 50Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac 51Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les
carburants52
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
53
Loi sur les emprunts de 2011 54Loi de 2011-2012 portant affectation de crédits 55
Syntesi Support Systems Inc. Fredericton 657666 2011 06 07
North Wind Farms Inc. Lower Knoxford 657764 2011 05 26
Nataly Convenience Store Inc. Tracadie-Sheila 657806 2011 05 29
MechMuffler and Custom Exhaust Inc. Little Ridge 657866 2011 06 01
Blessing Capital Inc. Moncton 657871 2011 06 01
Gemstone Properties & Developments Inc. Riverview 657890 2011 06 01
L.J. Rénovations Experts Inc. Eel River Crossing 657912 2011 06 02
657913 NB Ltd. Dawson Settlement 657913 2011 06 02
SPACEVENT MANUFACTURING INC. Bass River 657914 2011 06 02
WEST AFRICA OIL SERVICES LTD. Fredericton 657917 2011 06 02
S.G.M. Trucking Inc. Rivière-Verte 657918 2011 06 02
657919 NB INC. Kingston 657919 2011 06 03
FURLONG TRUCKING LTD. Doaktown 657929 2011 06 03
Munchie Masters Vending Ltd. Stilesville 657931 2011 06 03
657933 NB LTD. Miramichi 657933 2011 06 03
La Villa d’Aurélie Inc. Acadieville 657937 2011 06 03
Anywhere Siding Inc. Moncton 657941 2011 06 03
Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 758 Gazette royale — 29 juin 2011
A.M.E. INTERNATIONAL LTD. Saint John 657942 2011 06 03
CMT Electric Inc. Quispamsis 657949 2011 06 04
KC Fish & Chips II Inc. Upper Derby 657952 2011 06 06
657959 N.B. Inc. Berwick 657959 2011 06 06
Silver Fox Productions Inc. Moncton 657963 2011 06 06
Château du bel âge Bouctouche Inc. Bouctouche 657964 2011 06 06
Limb To Limb Tree Care Ltd. Lutes Mountain 657965 2011 06 06
Dr. Joshua L. Tracey Professional Corporation Quispamsis 657966 2011 06 06
Entreprises ADFN Nadeau Inc. Edmundston 657969 2011 06 06
Advance Drywall & Plastering Ltd. Saint-Antoine 657970 2011 06 07
NGAF RESEARCH INC. Bay du Vin 657971 2011 06 07
S. DOUCET DESIGN INC. Saint-Laurent 657973 2011 06 07
GLS LOGGING INC. Saint-Jacques 657974 2011 06 07
ENTREPRISES MARTIN THERIAULT (2011) INC. Grand-Sault / Grand Falls 657981 2011 06 07
Atlantic Digital Automation Inc. Miramichi 657988 2011 06 07
CENTRE DE SANTÉ AUDITIVE Edmundston 657991 2011 06 07FRANCISCA MORNEAULT INC.
657992 NB INC. Moncton 657992 2011 06 07
Rayz Enterprise Ltd. Fredericton 657995 2011 06 08
BC Cedar Homes Inc. Fredericton 657997 2011 06 08
657998 N.B. LIMITED Dieppe 657998 2011 06 08
CPCE HOLDINGS LTD. Fredericton 657999 2011 06 08
Steven Lavoie Snow Removal & Lawn Care Inc. Irishtown 658005 2011 06 08
Simple Joys Incorporated Saint John 658008 2011 06 08
RAK Marine International Inc. Shediac 658009 2011 06 08
E & L FOREST PRODUCTS INC. Saint-Jacques 658014 2011 06 08
DR. SHERIEF KAMEL PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 658015 2011 06 08
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales
In relation to a certificate of incorporation issued on May 9, 2011 under the name of “Delman Holdings Ltd.”, being corporation #657418, noticeis given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the director “RichardAtkitt” to “Richard Akitt”.
Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 9 mai 2011 à « Delman Holdings Ltd. » dont le numéro de corpora-tion est 657418, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom de l’administrateur « RichardAtkitt » à « Richard Akitt ».
_____________________________________________________
The Royal Gazette — June 29, 2011 759 Gazette royale — 29 juin 2011
TRELOCK NORTH AMERICA LTD. Saint John Ontario 657867 2011 06 01
_____________________________________________________
R & H ENTERPRISES LTD./LTEE 507986 2011 06 06
514264 N.B. Inc. 514264 2011 06 06
CANADIAN BURGER & FRY COMPANY LTD. 609966 2011 06 06
634902 NB LTD. 634902 2011 06 06
657461 NB Ltd. 657461 2011 06 07
_____________________________________________________
SANDY POINT PARK (2011) INC./ SANDY POINT PARK INC./ 049632 2011 06 02PARC POINTE AUX SABLES (2011) INC. PARC POINTE AUX SABLES INC.
620076 NB INC. LA BOULE D’OR INC. 620076 2011 05 19
David N. Rogers Professional Corporation 652980 N.B. LTD. 652980 2011 06 07
HENNBURN HOLDINGS LIMITED 657596 N.B. Ltd. 657596 2011 06 02
_____________________________________________________
ENTERRA HOLDINGS LTD. 055693 2011 06 06
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :
Previous ReferenceJurisdiction Number Date
Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :
DatePrevious name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of arrangement has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’arrangement a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 760 Gazette royale — 29 juin 2011
Restaurant Le Patrimoine Inc. CLUB DE GOLF Saint-Jacques 657887 2011 05 30LE PATRIMOINE LTEERestaurant Le Patrimoine Inc.
Southwest Contractors Ltd. LONGHILL ENTERPRISES INC. Gordonsville 657896 2011 06 01Southwest Contractors Ltd.
_____________________________________________________
DAMON SUPERMARKETS LTD. Cambridge-Narrows 004761 2011 06 02
MARTIN TRAILER SALES LTD. Edmundston 010695 2011 06 01
059707 N.B. LTD. Saint John 059707 2011 05 31
Randal Black Trucking Inc. Mill Cove 514977 2011 05 30
CORORA PROPERTIES INC. Dieppe 626281 2011 05 31
Red Head Fisheries Ltd. Seeleys Cove 628911 2011 05 30
SM TRADE CORP. INC. Moncton 642061 2011 06 03
643315 NB LTD. Moncton 643315 2011 06 07
_____________________________________________________
A.E.S. CONSULTANTS LTD. 000066 2011 06 01
BARC LTD. 010202 2011 06 01
DELAGARDE & ROBICHAUD LIMITEE 041475 2011 06 03
Senarius Inc. 509828 2011 06 07
511143 N.B. INC. 511143 2011 05 27
ACCIDENT ANALYSIS CONSULTANTS (2001) LTD. 515227 2011 05 27
BAK Holdings Ltd. 600759 2011 06 07
ASIAN PALACE INC. 606728 2011 05 30
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :
ReferenceNumber Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 761 Gazette royale — 29 juin 2011
Cashin’s Home Accents Inc. 607287 2011 05 27
617809 N.B. Ltd. 617809 2011 06 08
_____________________________________________________
D.P. MURPHY INC. Île-du-Prince-Édouard / SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657611 2011 05 31Prince Edward Island Fredericton
BANFF CONSTRUCTORS LTD. Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657624 2011 05 18Saint John
Gestion L.Y.N. Inc. Québec / Quebec Michel Arsenault 657692 2011 05 20Moncton
Shremshock Engineering, Inc. Ohio Deborah M. Power 657744 2011 05 25Fredericton
BFI CONSTRUCTORS LTD. Colombie-Britannique / SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657755 2011 05 26British Columbia Saint John
7853831 CANADA INC. Canada Rémi Poirier 657762 2011 05 26MacDougall Settlement
Sovereign Asset Management Inc. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657780 2011 05 27Saint John
Neate Construction Ltd. Alberta David Neate 657792 2011 05 27Mayfield
MortgageBrokers.com Financial Canada Glen Ward 657823 2011 05 30Group of Companies Inc. Shediac
7865813 Canada Inc. Canada William J. Parsley 657836 2011 05 31Moncton
COLD ROCK RESOURCES LTD. Alberta Paul Lemmon 657884 2011 06 01New Maryland
7317352 Canada Inc. Canada Nicole E. Druckman 657886 2011 06 01Moncton
Schroder Fund Advisors LLC Delaware SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657899 2011 06 02Saint John
Banque Nationale Planification et Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657900 2011 06 02avantages sociaux Inc. / National Bank Saint JohnPlanning and Benefits Inc.
NBC Assistance Inc. / Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657901 2011 06 02BNC Assistance inc. Saint John
2276485 ONTARIO INC. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657904 2011 06 02Saint John
1831260 Ontario Ltd. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657905 2011 06 02Saint John
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 762 Gazette royale — 29 juin 2011
CMLS FINANCIAL LTD. Canadian Mortgage Loan Services Limited 656460 2011 06 07
TD EQUIPMENT FINANCE CANADA INC. CAPITAL UNDERWRITERS INC. 657652 2011 05 19
Sunwing Vacations Inc./Vacances Sunwing Inc. Sunwing Tours Inc. 657808 2011 05 30
Sunwing Tours Inc. Red Seal Tours Inc. 657808 2011 05 30
_____________________________________________________
R. MOREAU & SON Manitoba Robert B. Moreau 018794 2011 06 06 2011 09 03LOGGING LTD.
Bowater Guérette Inc. Québec / Quebec Walter D. Vail 075679 2011 06 06 2011 09 03
Baker, Thomsen Associates Californie / California Deborah M. Power 076473 2011 06 06 2011 09 03Insurance Services
ORLEANS MARITIMES INC. Canada Tracy L. Wong 609930 2011 06 06 2011 09 03
JAZZ AIR HOLDING GP INC. / Canada SMSS Corporate 623353 2011 06 06 2011 09 03COMMANDITÉ GESTION Services (NB) Inc.JAZZ AIR INC.
Poultry Insurance Exchange Ontario April Sexsmith 640085 2011 06 06 2011 09 03Reciprocal of CanadaFonds d’échange d’assurance Avicole réciproque du Canada
ELNIC INC. Québec / Quebec Guildo Racine 650649 2011 06 06 2011 09 03
PATHWAY OIL & GAS 2010 INC. Ontario Walter D. Vail 651902 2011 06 06 2011 09 03
THE ART OF RESULTS INC. Canada Rick Lingley 652117 2011 06 06 2011 09 03
_____________________________________________________
PIONEER HI-BRED CANADA HOLDINGS Ontario Franklin O. Leger 019232 2011 06 04LIMITED Saint John
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :
ReferenceNumber Date
Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex-traprovinciales suivantes :
Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée
Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given, under the Business CorporationsAct, of the cancellation of the registration of the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis d’annulation a été émis aux corporations extraprovincialessuivantes :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 763 Gazette royale — 29 juin 2011
KÄRCHER CANADA INC. Canada Paul Smith 073047 2011 06 04Saint John
ATLANTIC BUSINESS FORMS LTD. Île-du-Prince-Édouard / Paul Emile Gauvin 603997 2011 06 04Prince Edward Island Riverview
TTE TECHNOLOGY CANADA LTD. Canada Franklin O. Leger 613186 2011 06 04TECHNOLOGIE TTE CANADA LTEE Saint John
World Kitchen Canada (EHI), Inc. Canada Deborah M. Power 624261 2011 06 04Fredericton
SANOFI-AVENTIS PHARMA INC. Canada SMSS Corporate Services 635899 2011 06 04(NB) Inc.Saint John
NATIONAL POST INC. Canada Len Hoyt 648090 2011 06 04Fredericton
BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED Ontario Edward Keys 653533 2011 06 04Saint John
_____________________________________________________
East Coast Online Inc. Canada SMSS Corporate Services 627211 2011 06 01(NB) Inc.Saint John
_____________________________________________________
CAPITAL UNDERWRITERS CAPITAL UNDERWRITERS INC. SMSS Corporate Services 657652 2011 05 19INC. (NB) Inc.
Saint John
United Rentals of Canada, Inc. UNITED RENTALS OF CANADA, SMSS Corporate Services 657733 2011 05 25INC. (NB) Inc.
Saint John
ABB INC. ABB Inc. David M. Norman 657796 2011 05 27Fredericton
ABB INC. ABB INC. David M. Norman 657797 2011 05 27Fredericton
Red Seal Tours Inc. First Choice Canada, Inc. / SMSS Corporate Services 657808 2011 05 30Premier Choix Canada Inc. (NB) Inc.
Saint John
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of reinstatement has been issued to the follow-ing extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de rétablissement a été émis aux corporations extrapro-vinciales suivantes :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :
ReferenceAgent and Address Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 764 Gazette royale — 29 juin 2011
Love and Learn Childcare Center Inc. Riverview 657715 2011 05 31
EGLISE DE L’ESPOIR D’EDMUNDSTON INC. Saint-Basile 657751 2011 06 01
LOCAL 362 - BREWERY & SOFT DRINK WORKERS INC. Saint John 657815 2011 05 30
LA FONDATION DES AMIS DU FOYER SAINT-THOMAS Memramcook 657834 2011 05 31DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK INC.
_____________________________________________________
VILLA DES-JARDINS INC. 016791 2011 05 31
FONDATION JÉRÉMY DES PETITS PAS D’ESPOIR INC.- 656318 2011 05 31JEREMY’S FOUNDATION LITTLE STEPS OF HOPE INC.
_____________________________________________________
THE SOUL CARE RESOURCE Soul Care Resource Centre Inc. 624113 2011 06 02CENTRE INC.
_____________________________________________________
COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX DES AÎNÉS 649106 2011 06 06DE L’ACADIE 2010 INC.
_____________________________________________________
Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :
ReferenceNumber Date
Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :
DateNew Name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,the surrender of charter has been accepted and the company has beendissolved:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, l’abandon dela charte des corporations suivantes a été accepté, et que celles-ci sontdissoutes :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 765 Gazette royale — 29 juin 2011
THE SOUTHERN NEW BRUNSWICK CATTLE PENNING CLUB INC. 024818 2011 05 31
Codiac Courier Claudette Martell Moncton 650726 2011 06 08
Festival des Châteaux de L’ASSOCIATION SPORTIVE Le Goulet 654067 2011 05 30Sable de Le Goulet DU GOULET INC.
BELL MEDIA RADIO NETWORK BELL MEDIA INC. Saint John 656985 2011 06 01
CAMBRIDGE LIFE SOLUTIONS Cambridge Life Solutions Inc. Fredericton 657462 2011 06 03NEGOTIATION SERVICES
Achievement Concepts - Sharon Allen Little Shemogue 657572 2011 05 17Training and Design Solutions
La belle bête toilettage pour Josiane Fournier Balmoral 657612 2011 05 17chiens et chats
Abeva Salon Mylene Bourbonnais Richibucto Road 657647 2011 06 01
Dundee Capital Markets Dundee Securities Ltd./ Saint John 657651 2011 05 19Valeurs Mobilieres Dundee Ltée
Canneberges NB Cranberries Canneberges NB Cranberries Point de Bute 657681 2011 05 20
Lewis Pharmacy Ryan C. Post Pharmacy Ltd. Perth-Andover 657691 2011 06 02
CELGENE Celgene Inc. Saint John 657703 2011 05 24
Skärpa Foto André C. Dugas Grande-Anse 657716 2011 06 01
NCP NCP NORTHLAND CAPITAL Saint John 657730 2011 05 25PARTNERS INC.
NORTHLAND CAPITAL NCP NORTHLAND CAPITAL Saint John 657731 2011 05 25PARTNERS PARTNERS INC.
UPP UNIPCO Purchasing Program Moncton 657737 2011 05 25
CFPP UNIPCO Purchasing Program Moncton 657738 2011 05 25
KOOPS Mowing & Other Services Jan Koops Marne 657741 2011 05 25
PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:
SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commercialesPartnerships and Business Names
Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 766 Gazette royale — 29 juin 2011
KEYNOTE CONFERENCE Michel Tremblay Fredericton 657752 2011 05 30INTERPRETATION SERVICES (MTI)
MICHEL TREMBLAY FRENCH Michel Tremblay Fredericton 657753 2011 05 30TO GO TRANSLATION SERVICES
TD EQUIPMENT FINANCE TD EQUIPMENT FINANCE Saint John 657781 2011 05 27CANADA INC.
Avéro Nettoyage Véronique Chaput Edmundston 657790 2011 05 27
Dean Yeomans Electric Dean Yeomans Plaster Rock 657793 2011 05 27
Gauvin Station Service Thomas Gauvin Haut-Lemèque 657795 2011 05 27
Motel Restaurant Bar La Faim Entreprise D. Michaud Inc. Saint-François 657810 2011 05 30De Match
Wajax Equipment / Équipement Wajax GP Holdco Inc. Moncton 657830 2011 05 30Wajax Wajax associé commandité
Holdco Inc.
Wajax Power Systems / Wajax GP Holdco Inc. Moncton 657831 2011 05 30Systèmes du Puissance Wajax Wajax associé commandité
Holdco Inc.
Wajax Industrial Components / Wajax GP Holdco Inc. Moncton 657832 2011 05 30Industriels Wajax Wajax associé commandité
Holdco Inc.
HANEYTOWN APARTMENTS Michael D. Wicketts Haneytown 657833 2011 05 30
Heavy Rayne Tattoos & Piercings Jonathan Comeau Fredericton 657837 2011 05 31
GREY POWER INSURANCE GP CAR AND HOME INC. / Saint John 657848 2011 05 31BROKERS MARITIMES GP AUTO ET HABITATION
INC.
Rusty Nail Pub L. A. C. REALTY LTD. Saint-Antoine 657872 2011 06 01
LO événementiel Lona Ouaïdou Ramadan Moncton 657883 2011 06 01
Dempsey Law Jason T. Dempsey Upper Coverdale 657894 2011 06 01
Baie Verte Pool & Spa Services 657393 NB Inc. Moncton 657906 2011 06 02
Evolving Solutions 634561 N.B. INC. Quispamsis 657907 2011 05 31
GC Cook In Services Genevieve Carbonneau Fredericton 657908 2011 06 02
La Quille d’Or 653546 NB INC. Rivière-à-la-Truite 657910 2011 06 02
Little-Pawz Dog Grooming Rachelle LeBlanc Dixon Point 657911 2011 06 02
Beaulieu Taxi Danny Beaulieu Saint-Basile 657915 2011 06 02
Dancing Dogs Café Katie Yeoman Sackville 657928 2011 06 03
Rachelle Standing Law Office Rachelle Standing Fredericton 657930 2011 06 03
Matt Downey Contracting Matthew Peter Ronald Downey Blackville 657932 2011 06 03
Riverview Logistics William Mason Riverview 657934 2011 06 03
Arcadia Construction Michel J. Francoeur Scoudouc Road 657939 2011 06 03
Mortar & Pestle Organic Farm Magali Bassaler-Khoury Bayside 657940 2011 06 03
The Royal Gazette — June 29, 2011 767 Gazette royale — 29 juin 2011
Jalerin Windor Services Jacques Richard Saint-Antoine 657943 2011 06 03
Mallain Consultants Monique Allain Fredericton 657945 2011 06 03
Mind Matters- Performance Monique Allain Fredericton 657946 2011 06 03Enhancement Consultants
S. Martin & Son Trucking Steven Martin St. Hilaire 657948 2011 06 03
Manuel’s Enterprises Josh Manuel Baie-Sainte-Anne 657950 2011 06 06
ACF WELDING Christian Dumont Edmundston 657951 2011 06 06
S. J. Doucet Electric Sylvio Doucet Moncton 657955 2011 06 06
TECHNICAL CONCEPTS Roger Poitras Saint-Léonard 657957 2011 06 06TECHNIQUES
Trn & Brn Trucking Jeremy Colford Blackville 657958 2011 06 06
Sarah Lyn Wilson Life Coach Sarah Wilson Saint John 657960 2011 06 06
TOPGUN ROOFING Denis Couture Petit-Rocher Ouest 657978 2011 06 07
DST Service & Repair Daniel Trites Moncton 657980 2011 06 07
Woolies Dryer Balls Shauntha Boyd Berry Mills 657982 2011 06 07
DANCO ENTERPRISE Daniel Collette Saine-Marie-de-Kent 657987 2011 06 07
J & S Outdoor Services James McGregor Lincoln 657994 2011 06 07
SIGN EXPERTS Nick Hansen Moncton 657996 2011 06 08
BYERS DECK AND FENCE Kirk Byers Saint John 658006 2011 06 08EXPERTS
GLAM TAN TANNING SALON Tracey Wright Hampton 658007 2011 06 08
_____________________________________________________
ATLANTIC TRADE Paul R. Jacques Saint John 301949 2011 06 02EVALUATION SERVICES
BUDGET CAB Donald L. Booker Fredericton 325766 2011 06 06
SUMMIT PUBLISHING Brunswick News Inc. Saint John 327768 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
MONCTON TIMES Brunswick News Inc. Moncton 327769 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
THE DAILY GLEANER Brunswick News Inc. Fredericton 327770 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
UNIVERSITY PRESS OF Brunswick News Inc. Fredericton 327771 2011 06 03NEW BRUNSWICK Nouvelles Brunswick Inc.
BRUNSWICK PRESS Brunswick News Inc. Fredericton 327772 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 768 Gazette royale — 29 juin 2011
OROMOCTO POST Brunswick News Inc. Oromocto 327773 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
THE ATLANTIC ADVOCATE Brunswick News Inc. Fredericton 327774 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
THE TIMES-TRANSCRIPT Brunswick News Inc. Moncton 327775 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
THE MONCTON TRANSCRIPT Brunswick News Inc. Moncton 327776 2011 06 03Nouvelles Brunswick Inc.
SIGNATURE VACATIONS Sunwing Vacations Inc./ Saint John 337131 2011 05 30Vacances Sunwing Inc.
Smitty’s Auto & Recreation Gerald E. Smith Centreville 346665 2011 06 02
Bubbles To Beauty Yvette Mazerolle Saint-Léonard 346765 2011 05 31
NHS Together in 2000 Harry Tretiak Hawkshaw 346800 2011 06 01
Magasin S.M.R. Thérèse Malet Saint-Sauveur 348869 2011 06 04
R.S. Black Welding and Fabricating Ray Black McKenna 349026 2011 06 01
TAYBERRY FARMS Dorian J. Beggs North Tay 349172 2011 06 03
NEVCO INTERNATIONAL Nevin J. Baric Neguac 350001 2011 05 31
Oromocto Power Kleen Services Robert Davis Oromocto 350006 2011 06 06
THUG ENGINE WORKS by AM Allan Millican Head of Millstream 351128 2011 06 02
Riverview After Hours Medical Coverdale After Hours Riverview 351418 2011 06 08Clinic Medical Clinic Ltd.
justforthefunofit Clare M. Brennan Fredericton 351593 2011 06 03
MORTON VENDING Mike Morton Beresford 351791 2011 06 01
INTERIM REHAB SERVICES Donna C. Lerette Moncton 351965 2011 06 03
Selloffvacations.com Sunwing Vacations Inc./ Saint John 619896 2011 05 30Vacances Sunwing Inc.
Common Cents Financial Services TODD D. SOPER FINANCIAL Quispamsis 624884 2011 06 02SERVICES INC.
Treejacks Doug Horsman Indian Mountain 625202 2011 06 08
Exit Realty Day’s Guy R. Day & Son Limited St. Stephen 625231 2011 06 01
BMO CAPITAL MARKETS/ BMO Nesbitt Burns Inc. Saint John 625796 2011 06 07BMO MARCHÉS DES CAPITAUX
ANTIQUES PLUS Rayburn Doucett Belledune 626029 2011 06 02
Len’s Original Good For You Leonard B. Lerette Moncton 626396 2011 06 03Products
Kelly Dallaire Esthetics Kelly Dallaire Fredericton 626503 2011 06 06
_____________________________________________________
The Royal Gazette — June 29, 2011 769 Gazette royale — 29 juin 2011
ALQ Electronics Skiff Lake 350069 2011 06 03
Baie Verte Pool & Spa Services Baie Verte 613100 2011 06 02
Advance Drywall & Plastering Saint-Antoine 618269 2011 06 07
REJ930 Ent. Prosser Brook 619341 2011 06 01
CFPP Moncton 649286 2011 05 25
Ô naturel... alimentation et produits naturels Beresford 649384 2011 05 26
GLS Logging Saint-Jacques 656966 2011 06 07
Trn & Brn Trucking Blackville 657958 2011 06 07
_____________________________________________________
EARTHBOUND TRIO MUSIC Dwayne Doucette Saint John 657617 2011 05 30Jessica Hamer
Ô Naturel Alimentation et Produits Diane Duguay Beresford 657765 2011 05 26Naturels Pierre Couture
The Sunshine and lollipops Shoppe Kimberly Ouellette Lincoln 657774 2011 05 26Pamela Mazerolle
Café c’est la vie Insoo David Shin Dieppe 657936 2011 05 09Heaok Ellen Youn
_____________________________________________________
Evolving Solutions Saint John 352374 2011 05 31
Codiac Courier Moncton 603983 2011 06 08
Avéro Nettoyage Edmundston 649718 2011 05 27
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :
Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — June 29, 2011 770 Gazette royale — 29 juin 2011
LINK Shareholder Services Fredericton Ontario Len Hoyt 657722 2011 05 24Canada LP FrederictonServices aux actionnaires LINK Canada SEC
EnerCare Solutions Limited Saint John Ontario SMSS Corporate Services 657860 2011 05 27Partnership (NB) Inc.
Saint John
Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour
Motor Vehicle Act Designation
Pursuant to subsection 15(1.1) of the Motor Vehicle Act of NewBrunswick, I hereby revoke all previous designations of fisheryofficers appointed under the Fisheries Act, being Chapter F-14of the Revised Statutes of Canada, 1985 and amendmentsthereto as peace officers for purposes of sections, 104, 105,105.1, 110 and 168 of the Motor Vehicle Act, R.S.N.B. 1973,Ch. M-17;And further pursuant to the provision of subsection 15(1.1) ofthe Motor Vehicle Act of New Brunswick, I hereby designate thefishery officers appointed under the Fisheries Act being ChapterF-14 of the Revised Statutes of Canada, 1985 and amendmentsthereto and named in the attached Schedule “A” as peace offic-ers for the purposes of sections, 104, 105, 105.1, 110 and 168 ofthe Motor Vehicle Act, R.S.N.B. 1973, Ch. M-17.
DATED at the City of Fredericton, Province of New Brunswick,this 3rd day of June, A.D, 2011.
Hon. Robert B. TrevorsMinister of Public Safety and Solicitor General
Schedule “A”ALBERT, GabrielARSENEAU, DanielleARSENEAU, EmileARSENEAULT, PaulAUGUSTINE, TylerAUSTIN, DavidBARCLAY, ChrisBARNES, RichardBARTLETT, MikeBATEMAN, GaryBATEMAN, Mitchell
Department ofPublic Safety
Désignation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
Conformément au paragraphe 15(1.1) de la Loi sur les véhiculesà moteur du Nouveau-Brunswick, je révoque par les présentesla nomination de tous les fonctionnaires de pêcheries nommésen vertu de la Loi sur les pêches, chapitre F-14 des Lois réviséesdu Canada de 1985, pour être agents de la paix aux fins des ar-ticles 104, 105, 105.1, 110 et 168 de la Loi sur les véhicules àmoteur, L.R.N.-B. 1973, c.M-17;Et toujours conformément aux dispositions du paragraphe15(1.1) de la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, je désigne par les présentes les fonctionnaires despêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches, chapitreF-14 des Lois révisées du Canada de 1985, et dont le nom figureà l’annexe A, agents de la paix aux fins des articles 104, 105,105.1, 110 et 168 de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B.1973, c.M-17.FAIT dans la cité de Fredericton, province du Nouveau-Brunswick, le 3 juin, 2011.
L’hon. Robert B. Trevorsministre de la Sécurité publique et solliciteur général du Nouveau-Brunswick
Annexe « A »ALBERT, GabrielARSENEAU, DanielleARSENEAU, EmileARSENEAULT, PaulAUGUSTINE, TylerAUSTIN, DavidBARCLAY, ChrisBARNES, RichardBARTLETT, MikeBATEMAN, GaryBATEMAN, Mitchell
Ministère de laSécurité publique
The Royal Gazette — June 29, 2011 771 Gazette royale — 29 juin 2011
BEAUCHAMP, SébastienBEEK, Richard E.BELLIVEAU, RonBENOIT, DominiqueBERNARD, TimothyBIEREN, Stacey MichelleBLANCHARD, RogerBLINN, HowardBOUCHARD, DenisBOUDREAU, Jean-JacquesBOUMA, PhillipBOWERS, Barry S.BREAU, MathieuBREAULT, JonathanBREAULT, Louis-MarieBRIDEAU, UlysseBROOKING, CherylBROOKS, Leonard R.BROWN, J. BruceBRYAN, SheldonBUDGE, Kevin G.BURGESS, RolandBUTLER, NicoleCHIASSON, PhilippeCHILDS, BobbiCHISHOLM, Graham A.CHUTE, BrendanCHUTE, Clarence E.CLARK, Anthony I.CLARKE-DOHERTY, LeishaCOLFORD, David RobertCOMEAU, Darrel V.COMEAU, DenisCOMEAU, EugeneCOMEAU, SteveCOMLEY, Mark A.CONRAD, ShelleyCOOK, G. ScottCOOLEN, LesleyCORKUM, Nicholas P.CORMIER, CharlesCRAWFORD, JaredCREMO, TimothyCROMWELL, Lawrence M.CURWIN, JamesCURWIN, RyanCYR, YvetteDAIGLE, DianeDAIGLE, RogerDAVIES, ToddDAYE, Christopher P.D’ENTREMONT, Felton P.D’ENTREMONT, NoelDEVEAU, Douglas ClarkDIONNE, MichelleDOBSON, Allan MurrayDOHERTY, TimDOLLARD, Francis William
BEAUCHAMP, SébastienBEEK, Richard E.BELLIVEAU, RonBENOIT, DominiqueBERNARD, TimothyBIEREN, Stacey MichelleBLANCHARD, RogerBLINN, HowardBOUCHARD, DenisBOUDREAU, Jean-JacquesBOUMA, PhillipBOWERS, Barry S.BREAU, MathieuBREAULT, JonathanBREAULT, Louis-MarieBRIDEAU, UlysseBROOKING, CherylBROOKS, Leonard R.BROWN, J. BruceBRYAN, SheldonBUDGE, Kevin G.BURGESS, RolandBUTLER, NicoleCHIASSON, PhilippeCHILDS, BobbiCHISHOLM, Graham A.CHUTE, BrendanCHUTE, Clarence E.CLARK, Anthony I.CLARKE-DOHERTY, LeishaCOLFORD, David RobertCOMEAU, Darrel V.COMEAU, DenisCOMEAU, EugeneCOMEAU, SteveCOMLEY, Mark A.CONRAD, ShelleyCOOK, G. ScottCOOLEN, LesleyCORKUM, Nicholas P.CORMIER, CharlesCRAWFORD, JaredCREMO, TimothyCROMWELL, Lawrence M.CURWIN, JamesCURWIN, RyanCYR, YvetteDAIGLE, DianeDAIGLE, RogerDAVIES, ToddDAYE, Christopher P.D’ENTREMONT, Felton P.D’ENTREMONT, NoelDEVEAU, Douglas ClarkDIONNE, MichelleDOBSON, Allan MurrayDOHERTY, TimDOLLARD, Francis William
The Royal Gazette — June 29, 2011 772 Gazette royale — 29 juin 2011
DONOVAN, PhillipDOUCET, KevinDOUCETTE, EugèreDREWES, Matthew C.DUGUAY, AlainDURELLE, DonaldDURELLE, Jean-PaulEMIN, Brian A.ENGLISH, DuncanFERGUSON, VictorFITZGERALD, CoreyFITZGERALD, Henry J.FLECK, Daniel F.FOUGERE, Norman J.FRANCIS, Allan G.FRANCIS, Andrew J.FRASER, Matthew J.FRIOLET, ÉricGAUDET, OdetteGIFFIN, Britton C.GILLAN, DanielGILLESPIE, GaryGILLESPIE, GlenGILLIS, KellyGIONET, Remi-MartinGLODE, Matthew ShawnGRACE, Mike G.GRAVES, JeffGREENLAW, Joseph S.HALLIDAY, HeatherHENDSBEE, Gavin B.HOBBS, LeslieHOLLAND, Peter E.HOPE, EarlHORNE, Donald JohnHUTCHINS, Gary F.HYNES, Jonathan M.INGERSOLL, Cameron V.IRWIN, Jeffrey L.JACKLYN, Gerald W.JACOB, FernandJARDINE, LloydJARDINE, MontgomeryJENKINS, Tara L.JONES, RossJOWETT, PeterJUTEAU, Kevin M.KENNEY, Gregory S.KIERSTEAD, James G. A.KLEISZ, PeterKNOCKWOOD, JosephKNOWLES, CurtLANDRY, AllainLANDRY, CharlesLANDRY, Douglas M.LANDRY, Marie-JoséeLANDRY, SoniaLANTEIGNE, Alban
DONOVAN, PhillipDOUCET, KevinDOUCETTE, EugèreDREWES, Matthew C.DUGUAY, AlainDURELLE, DonaldDURELLE, Jean-PaulEMIN, Brian A.ENGLISH, DuncanFERGUSON, VictorFITZGERALD, CoreyFITZGERALD, Henry J.FLECK, Daniel F.FOUGERE, Norman J.FRANCIS, Allan G.FRANCIS, Andrew J.FRASER, Matthew J.FRIOLET, ÉricGAUDET, OdetteGIFFIN, Britton C.GILLAN, DanielGILLESPIE, GaryGILLESPIE, GlenGILLIS, KellyGIONET, Remi-MartinGLODE, Matthew ShawnGRACE, Mike G.GRAVES, JeffGREENLAW, Joseph S.HALLIDAY, HeatherHENDSBEE, Gavin B.HOBBS, LeslieHOLLAND, Peter E.HOPE, EarlHORNE, Donald JohnHUTCHINS, Gary F.HYNES, Jonathan M.INGERSOLL, Cameron V.IRWIN, Jeffrey L.JACKLYN, Gerald W.JACOB, FernandJARDINE, LloydJARDINE, MontgomeryJENKINS, Tara L.JONES, RossJOWETT, PeterJUTEAU, Kevin M.KENNEY, Gregory S.KIERSTEAD, James G. A.KLEISZ, PeterKNOCKWOOD, JosephKNOWLES, CurtLANDRY, AllainLANDRY, CharlesLANDRY, Douglas M.LANDRY, Marie-JoséeLANDRY, SoniaLANTEIGNE, Alban
The Royal Gazette — June 29, 2011 773 Gazette royale — 29 juin 2011
LANTZ, Thomas R.LEBLANC, ArthurLEBLANC, JeanLEGERE ConradLEGRESLEY, Jean-ClaudeLEONARD, JacquesLEVESQUE, MarcLEVESQUE, MauriceLEVI, KennethLEVI, RichardLEWIS, WarrenLOCKE, StephenLUSHINGTON, TrevorMacDONALD, Gary L.MacDONALD, Gary M.MacDONALD, CraigMacDONALD, John S.MacEWEN, MatthewMacINNIS, RobertMacINTOSH, Eric C.MacINTYRE, JohnMacISAAC, ShaneMacKELLAR, Collin J.MacKINNON, GerardMacLEAY, JacobMacPHEE, NadiaMacRAE, Kent TrevorMAGILL, Paul D.MALLET, J.C. DanielMANDERSON, StewartMANDERVILLE, DarinMARTIN, DonatMARTIN, EdmondMATHESON, ChristopherMcCLEAVE, RaeMcDANIEL, MatthewMcFARLANE, MichelMcGRAW, YvonMcINNIS, OttisMcKINNON, R. JimMcLEAN, AllanMcLEOD, ToddMcNALLY, Joyce B.MILLAR-LAPOINTE, GenevièveMOORE, BenMORASH, PaulMORRIS, Edmund JosephMORRISSEY, CindyMOSSMAN, Scott A.MUISE, DwayneMURRAY, GregNEWELL, NicoleOICKLE, Dave J.OWEN, Timothy J.PARKER, HughPARSONS, Derreck J.PARSONS, MarkPELRINE, Tanya
LANTZ, Thomas R.LEBLANC, ArthurLEBLANC, JeanLEGERE ConradLEGRESLEY, Jean-ClaudeLEONARD, JacquesLEVESQUE, MarcLEVESQUE, MauriceLEVI, KennethLEVI, RichardLEWIS, WarrenLOCKE, StephenLUSHINGTON, TrevorMacDONALD, Gary L.MacDONALD, Gary M.MacDONALD, CraigMacDONALD, John S.MacEWEN, MatthewMacINNIS, RobertMacINTOSH, Eric C.MacINTYRE, JohnMacISAAC, ShaneMacKELLAR, Collin J.MacKINNON, GerardMacLEAY, JacobMacPHEE, NadiaMacRAE, Kent TrevorMAGILL, Paul D.MALLET, J.C. DanielMANDERSON, StewartMANDERVILLE, DarinMARTIN, DonatMARTIN, EdmondMATHESON, ChristopherMcCLEAVE, RaeMcDANIEL, MatthewMcFARLANE, MichelMcGRAW, YvonMcINNIS, OttisMcKINNON, R. JimMcLEAN, AllanMcLEOD, ToddMcNALLY, Joyce B.MILLAR-LAPOINTE, GenevièveMOORE, BenMORASH, PaulMORRIS, Edmund JosephMORRISSEY, CindyMOSSMAN, Scott A.MUISE, DwayneMURRAY, GregNEWELL, NicoleOICKLE, Dave J.OWEN, Timothy J.PARKER, HughPARSONS, Derreck J.PARSONS, MarkPELRINE, Tanya
The Royal Gazette — June 29, 2011 774 Gazette royale — 29 juin 2011
PERREAULT, ClaudePHILLIPS, Scott R. D.PIERRO, StephenPIKE, CatherinePOIRIER, CamillePROSPER, AdamPROSPER, PhillipPROSSER, Perry R.RACE, James E.RANDALL, MichaelRATH, RitchieREID, JoanRICHARD, DanielRICHARD, LouisRICHARD, SylvioRICHARDS, B. DaleROBICHAUD, Denis F.ROBICHAUD, LucROBINSON, NelsonROSS, BernardROUSELLE, ElenaROWE, DerekROY, Andre E.ROY, RobertSAMPSON, NicoleSAVOY, StephenSCHUYLER, Jeffrey S.SCOTT, WilliamSENECHAL, RonaldSETO, KimSHEIDOW, DonaldSHEIDOW, JeffSHUTE, James RobertSINCLAIR, David L.SMITH, R. HectorSMITH, Norman E.SMITH, Vincent H.SOCK, JasonSPERRY, Christopher JohnSQUIRES, DonnaSt-COEUR, JohnSTEVENS, ToddSTEWART, Lee A.STEWART, StanleySTUART, John P.STURGEON, KendallSURETTE, DwayneTAYLOR, PeterTHERRIEN, KennyTHIBODEAU, StephanTHOMPSON, WayneTIMMONS, GrantVICKERS, Wendy J.WADDELL, LindsayWARD, PatrickWATERMAN, JaredWEBSTER, CoreyWHITTY, Barry
PERREAULT, ClaudePHILLIPS, Scott R. D.PIERRO, StephenPIKE, CatherinePOIRIER, CamillePROSPER, AdamPROSPER, PhillipPROSSER, Perry R.RACE, James E.RANDALL, MichaelRATH, RitchieREID, JoanRICHARD, DanielRICHARD, LouisRICHARD, SylvioRICHARDS, B. DaleROBICHAUD, Denis F.ROBICHAUD, LucROBINSON, NelsonROSS, BernardROUSELLE, ElenaROWE, DerekROY, Andre E.ROY, RobertSAMPSON, NicoleSAVOY, StephenSCHUYLER, Jeffrey S.SCOTT, WilliamSENECHAL, RonaldSETO, KimSHEIDOW, DonaldSHEIDOW, JeffSHUTE, James RobertSINCLAIR, David L.SMITH, R. HectorSMITH, Norman E.SMITH, Vincent H.SOCK, JasonSPERRY, Christopher JohnSQUIRES, DonnaSt-COEUR, JohnSTEVENS, ToddSTEWART, Lee A.STEWART, StanleySTUART, John P.STURGEON, KendallSURETTE, DwayneTAYLOR, PeterTHERRIEN, KennyTHIBODEAU, StephanTHOMPSON, WayneTIMMONS, GrantVICKERS, Wendy J.WADDELL, LindsayWARD, PatrickWATERMAN, JaredWEBSTER, CoreyWHITTY, Barry
The Royal Gazette — June 29, 2011 775 Gazette royale — 29 juin 2011
WILLIAMS, John N.WOLFE, William J.WOOD, Bryan M.YEATON, Bradley J.YOUNG, Eldon S.YOUNG, W. Patrick
________________
SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after June 29, 2011:
1994, Saturn SW1Serial No. 1G8ZG8596RZ221095License Plate: BQL368Registered Owner: Tory Andrew BaldwinVehicle located at George Leger’s Towing, Shediac
1994, Ford Ranger Pick-UpSerial No. 1FTCR10A8RPB86117License Plate: CJM013Registered Owner: Clark L. TurnerVehicle located at George Leger’s Towing, Shediac
TO: TIMBERLAND REALTY INC., as Mortgagor of prop-erty as identified as PIDs 00601492, 00601484 and 05087655,located at Prosser Brook Road, in the Parish of Elgin andCounty of Albert, New Brunswick;
AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at Prosser BrookRoad, Parish of Elgin, in the County of Albert and Province ofNew Brunswick. Notice of Sale given by Cyril Eugene Mullin,holder of first mortgage. Sale on the 22nd day of July, 2011, at11:00 a.m., at or near the lobby of the Riverview Town Hall,30 Honor House Court, Riverview, New Brunswick. See adver-tisement in the Telegraph-Journal.
DATED at Miramichi, New Brunswick, this 8th day of June,2011.
Aloysius Hayes, URQUHART & HAYES, Barristers & So-licitors, P.O. Box 501, Suite 201, Miramichi, New BrunswickE1V 3M6, Tel. 506-627-0091, Fax 506-627-0096, Solicitorsfor the Mortgagee, Cyril Eugene Mullin
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Robert Leslie Sommerville, original Mortgagor; and to allothers whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts
Notices of Sale
WILLIAMS, John N.WOLFE, William J.WOOD, Bryan M.YEATON, Bradley J.YOUNG, Eldon S.YOUNG, W. Patrick
________________
VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 29 juin 2011 :
Saturn SW1 1994Numéro de série : 1G8ZG8596RZ221095Numéro d’immatriculation : BQL368Propriétaire immatriculé : Tory Andrew BaldwinVéhicule se trouvant actuellement chez George Leger’sTowing, ShediacCamionnette Ford Ranger 1994Numéro de série : 1FTCR10A8RPB86117Numéro d’immatriculation : CJM013Propriétaire immatriculé : Clark L. TurnerVéhicule se trouvant actuellement chez George Leger’sTowing, Shediac
DESTINATAIRES : TIMBERLAND REALTY INC., débi-teur hypothécaire des biens situés sur le chemin de ProsserBrook, paroisse d’Elgin, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick, et dont les numéros d’identification sont 00601492,00601484 et 05087655;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au chemin de Prosser Brook, pa-roisse d’Elgin, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par Cyril Eugene Mullin, titu-laire de la première hypothèque. La vente aura lieu le22 juillet 2011, à 11 h, dans le foyer de l’hôtel de ville deRiverview, ou tout près, 30, cour Honour House, Riverview(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans leTelegraph-Journal.FAIT à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, le 8 juin 2011.
Aloysius Hayes, du cabinet URQUHART & HAYES,C.P. 501, bureau 201, Miramichi (Nouveau-Brunswick)E1V 3M6, tél. 506-627-0091, téléc. : 506-627-0096, avocatsdu créancier hypothécaire, Cyril Eugene Mullin
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataires : Robert Leslie Sommerville, débiteur hypothé-caire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de
Avis de vente
The Royal Gazette — June 29, 2011 776 Gazette royale — 29 juin 2011
in amendment thereof. Freehold property being situated at632 Grove Hill Road, Grove Hill, New Brunswick, the same lotconveyed to Robert Leslie Sommerville by Transfer registeredin the Land Titles Office on October 23, 2002, as documentnumber 15242275.
Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at theHampton Court House located at 648 Main Street, Hampton,New Brunswick, on the 13th day of July, 2011, at the hour of11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale inthe Telegraph-Journal dated June 14, June 21, June 28 and July5, 2011.
McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: MathieuR. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: John Henry Corcoran, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 803 Highway385, Sisson Brook, New Brunswick, the same lot conveyed toJohn Henry Corcoran by Transfer registered in the Land TitlesOffice on May 24, 2007, as document number 23871396.
Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia. Sale to beheld at the Grand Falls Town Hall at 131 Pleasant Street, GrandFalls, New Brunswick, on the 13th day of July, 2011, at the hourof 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale inThe Victoria Star dated June 15, June 22, June 29 and July 6,2011.
McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Bonnie Lynn McCarl, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 1196 RR 16,Jolicure, New Brunswick, the same lot conveyed to BonnieLynn McCarl by Transfer registered in the Land Titles Office onNovember 27, 2009, as document number 28095645.
Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Moncton City Hall located at 655 Main Street,Moncton, New Brunswick, on the 14th day of July, 2011, at the
la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19. Biens en tenure li-bre situés au 632, chemin Grove Hill, Grove Hill (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré àRobert Leslie Sommerville par l’acte de transfert enregistré aubureau d’enregistrement foncier le 23 octobre 2002, sous le nu-méro 15242275.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 13 juillet 2011, à 11 h, heure locale, au palais de justicede Hampton situé au 648, rue Main, Hampton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des14, 21 et 28 juin, et du 5 juillet 2011 du Telegraph-Journal.
Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataires : John Henry Corcoran, débiteur hypothécaire ori-ginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19. Biens en tenure libre situésau 803, route 385, Sisson Brook (Nouveau-Brunswick), corres-pondant au même lot ayant été transféré à John Henry Corcoranpar l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrementfoncier le 24 mai 2007, sous le numéro 23871396. Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. Lavente aura lieu le 13 juillet 2011, à 11 h, heure locale, à l’hôtelde ville de Grand-Sault, 131, rue Pleasant, Grand-Sault(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes15, 22 et 29 juin, et du 6 juillet 2011 du journal The VictoriaStar.
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataires : Bonnie Lynn McCarl, débitrice hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19. Biens en tenure libresitués au 1196, R.R. 16, Jolicure (Nouveau-Brunswick), et cor-respondant au même lot ayant été transféré à Bonnie LynnMcCarl par l’acte de transfert enregistré au bureau d’enregistre-ment foncier le 27 novembre 2009, sous le numéro 28095645.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 14 juillet 2011, à 11 h, heure locale, à l’hôtelde ville de Moncton situé au 655, rue Main, Moncton
The Royal Gazette — June 29, 2011 777 Gazette royale — 29 juin 2011
hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice ofSale in the Times & Transcript dated June 16, June 23, June 30and July 7, 2011.
McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street,Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick,E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
TO: DARREN ANDREW GREEN;AND TO: ERIN ELIZABETH GREEN;AND TO: PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED(previously known as CARLETON PIONEER CREDITUNION LIMITED);AND TO: CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORA-TION;AND TO: NEW BRUNSWICK LEGAL AID SERVICESCOMMISSION;AND TO: ALLAN MARSHALL & ASSOCIATES INC.NOTICE IS HEREBY GIVEN that under and by virtue of a cer-tain Indenture of Mortgage bearing date the 19th day of March,2007 and registered in the Office of the Registrar of Deeds inand for the County of Carleton on the 30th day of March, 2007as Number 23629828 made between DARREN ANDREWGREEN AND ERIN ELIZABETH GREEN, as Mortgagorsand PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED (previ-ously known as CARLETON PIONEER CREDIT UNIONLIMITED), as Mortgagee, and under and by virtue of the Prop-erty Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, there will, for the purpose ofobtaining payment of monies secured by the said Indenture ofMortgage, default having been made in the payment thereof, besold at public auction at the offices of McCue BrewerDickinson, 179 Broadway Street, Woodstock, NewBrunswick, on 11th day of July, 2011, at the hour of eleveno’clock (11:00 a.m.) in the forenoon, local time, the lands andpremises known as House and Lot, 194 Gregg SettlementRoad, Gregg Settlement, New Brunswick and having PIDnumber 10250132.DATED at the Town of Woodstock, in the Province of NewBrunswick, this 10th day of June, 2011.
Progressive Credit Union Limited (previously known asCarleton Pioneer Credit Union Limited), Per: James H.McCue, Solicitor for Mortgagee
For further particulars of the sale apply to: James H. McCue,Solicitor for Mortgagee, 179 Broadway Street, Woodstock, NBE7M 1B7, Tel: 506-325-2835, Fax: 506-328-6248
________________
TO: GERALD FRANCIS WOODS, Mortgagor;
AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended.Freehold property situate at 395 Edward Street, Miramichi,
(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 16, 23 et 30 juin et du 7 juillet 2011 du Times & Transcript.
Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laSociété hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rueMain, bureau S400, C. P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970, télécopieur :506-857-4095
________________
DESTINATAIRES : DARREN ANDREW GREEN;ERIN ELIZABETH GREEN;PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED (ancienne-ment connue sous le nom de CARLETON PIONEER CRE-DIT UNION LIMITED);CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST;
LA COMMISSION DES SERVICES D’AIDE JURI-DIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK;ALLAN MARSHALL & ASSOCIATES INC.SACHEZ qu’en vertu de l’acte d’hypothèque constitué le19 mars 2007, et enregistré au bureau de l’enregistrement ducomté de Carleton le 30 mars 2007, sous le numéro 23629828,entre DARREN ANDREW GREEN ET ERINELIZABETH GREEN, débiteurs hypothécaires, et PRO-GRESSIVE CREDIT UNION LIMITED (anciennementconnue sous le nom de CARLETON PIONEER CREDITUNION LIMITED), créancière hypothécaire, en vertu de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, seront vendus aux en-chères publiques en vue d’acquitter les sommes garanties par le-dit acte d’hypothèque, étant donné le défaut d’en effectuer lepaiement, au cabinet d’avocats McCue Brewer Dickinson,179, rue Broadway, Woodstock (Nouveau-Brunswick), le11 juillet 2011, à 11 h, heure locale, le terrain et les bâtiments,connus comme la maison et lot situés au 194, chemin GreggSettlement, Gregg Settlement (Nouveau-Brunswick), et dontle NID est 10250132.
FAIT dans la ville de Woodstock, province du Nouveau-Brunswick, le 10 juin 2011.
Progressive Credit Union Limited (anciennement connuesous le nom de Carleton Pioneer Credit Union Limited),créancière hypothécaire, par son avocat James H. McCue
Pour obtenir plus de détails relativement à la vente, communi-quer avec James H. McCue, avocat de la créancière hypothé-caire, 179, rue Broadway, Woodstock (Nouveau-Brunswick)E7M 1B7, tél. : 506-325-2835; téléc. : 506-328-6248
________________
DESTINATAIRES : GERALD FRANCIS WOODS, débi-teur hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 395, rue Edward,
The Royal Gazette — June 29, 2011 778 Gazette royale — 29 juin 2011
Northumberland County, Province of New Brunswick andknown as Parcel Identifier Number 40172892.
Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINIONBANK.The sale is scheduled for Thursday, July 28, 2011, at 11:00 a.m.,at the Miramichi Court House, 673 King George Highway,Miramichi, New Brunswick.See advertisements in the Miramichi Leader in the issues ofJune 29, July 6, July 13 and July 20, 2011.
THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for TheToronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
TO: Miramichi Wreath Company Ltd., owner of the Equity ofRedemption and Original Mortgagor; Boiestown EnterprisesLtd. (mortgagee and assignee); Shikatehawk Maple Farms Ltd.;Royal Bank of Canada; Canada Revenue Agency; and to allothers whom it may concern.
Sale under the provisions of a Mortgage dated November 9,2006 between Miramichi Wreath Company Ltd as Mortgagor,and Kimberley Jean Smith and assigned to BoiestownEnterprises Ltd., as Mortgagee, and registered in the Registry ofLand Titles under the Land Titles Act for the District ofNorthumberland on July 28, 2009 as Number 27607853 (the“Mortgage”) and under section 44 of the Property Act, R.S.N.B.1973, c.P-19 lands being identified by PID No. 40077729 andPAN No. 02703133, and as more particularly described in theMortgage.
Notice of sale is given by Boiestown Enterprises Ltd., holder ofthe Mortgage. Sale on July 14, 2011, at the hour of 2:00 p.m.,by public auction at the Miramichi Court House, 673 KingGeorge Highway, Miramichi, New Brunswick. See advertise-ments in the Miramichi Leader of June 20, June 27, July 4 andJuly 11, 2011.
Boiestown Enterprises Ltd., holder of the Mortgage, throughIan S. Purvis, Q.C., Law Office, Solicitor for Boiestown Enter-prises Ltd.
________________
To: Estate of Donald A. Déspres, also known as Joseph AntoineDéspres, of Bouctouche, in the County of Kent and Province ofNew Brunswick, Mortgagor;
And to: Denise Goguen, of Bouctouche, in the County of Kentand Province of New Brunswick, Estate Representative;And to: All heirs and beneficiaries of the Estate of the lateDonald A. Déspres, also known as Joseph Antoine Déspres;
And to: All others whom it may concern.
Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est40172892.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 28 juillet 2011, à 11 h, au palais dejustice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi(Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 29 juin et des 6, 13et 20 juillet 2011 du Miramichi Leader.
Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER,avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD CanadaTrust)
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
DESTINATAIRES : Miramichi Wreath Company Ltd., pro-priétaire du droit de rachat et débitrice hypothécaire originaire;Boiestown Enterprises Ltd. (créancière hypothécaire et cession-naire); Shikatehawk Maple Farms Ltd.; Banque Royale duCanada; Agence du revenu du Canada; et tout autre intéressééventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que établi le 9 novembre 2006 entre Miramichi Wreath Com-pany Ltd., débitrice hypothécaire, et Kimberley Jean Smith, etcédé à Boisetown Enterprises Ltd., créancière hypothécaire, le-dit acte ayant été enregistré au registre des titres fonciers pourle district de Northumberland, en vertu de la Loi sur l’enregis-trement foncier, le 28 juillet 2009, sous le numéro 27607853(« l’hypothèque ») et en vertu de l’article 44 de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19. Le terrain, plus précisément dé-signé dans l’acte d’hypothèque, a le numéro d’identification40077729 et le numéro d’évaluation 02703133.Avis de vente donné par Boiestown Enterprises Ltd., titulaire del’hypothèque. La vente par encan public aura lieu le14 juillet 2011, à 14 h, au palais de justice de Miramichi,673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 20 et 27 juin et des4 et 11 juillet 2011 du Miramichi Leader.
Ian S. Purvis, c.r., du cabinet Ian S. Purvis, avocat de la titulairede l’hypothèque, Boiestown Enterprises Ltd.
________________
Destinataires : La succession de Donald A. Déspres, égalementconnu sous le nom de Joseph Antoine Déspres, de Bouctouche,comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hy-pothécaire;Denise Goguen, de Bouctouche, comté de Kent, province duNouveau-Brunswick, représentante de la succession;Tous les héritiers et les ayants droit de la succession de feuDonald A. Déspres, également connu sous le nom de JosephAntoine Déspres;Et tout autre intéressé éventuel.
The Royal Gazette — June 29, 2011 779 Gazette royale — 29 juin 2011
Freehold premises situate, lying and being at 28 McLaughlinStreet, Bouctouche, in the County of Kent and Province of NewBrunswick, also known as PID Number 25074782.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 20th day of July, 2011, at 1:30 p.m., at the Town Hallin Bouctouche, 211 Irving Boulevard, Bouctouche, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
________________
To: Ronald Eric Clare, of the Town of Riverview, in the Countyof Albert and Province of New Brunswick, Mortgagor;
And To: Katherine Anne Clare, of the Town of Riverview, in theCounty of Albert and Province of New Brunswick, Spouse ofthe Mortgagor;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 27 AshburnAvenue, in the Town of Riverview, in the County of Albert andProvince of New Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 22nd day of July, 2011, at 11:30 a.m., at the TownHall in Riverview, 30 Honour House Court, Riverview, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
________________
To: Lisa Marie Sprague of the City of Fredericton, in the Countyof York and Province of New Brunswick, Mortgagor;
And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 116 Jaffrey Street,in the City of Fredericton, in the County of York and Provinceof New Brunswick, PID #1423250.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 17th day of August, 2011, at 11:00 a.m., at the CourtHouse in Fredericton, 427 Queen Street, Fredericton, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement inThe Daily Gleaner.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
________________
Lieux en tenure libre situés au 28, rue McLaughlin,Bouctouche, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick,et dont le NID est 25074782.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 20 juillet 2011, à 13 h 30, à l’hôtel de villede Bouctouche, 211, boulevard Irving, Bouctouche (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
________________
Destinataires : Ronald Eric Clare, de la ville de Riverview,comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hy-pothécaire;Katherine Anne Clare, de la ville de Riverview, comté d’Albert,province du Nouveau-Brunswick, conjointe du débiteur hypo-thécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 27, avenue Ashburn, ville deRiverview, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick.
Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 22 juillet 2011, à 11 h 30, à l’hôtel de villede Riverview, 30, cour Honour House, Riverview (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
________________
Destinataires : Lisa Marie Sprague, de la ville de Fredericton,comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hy-pothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 116, rue Jaffrey, ville deFredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick,et dont le NID est 1423250.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 17 août 2011, à 11 h, au palais de justicede Fredericton, 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le journal The Daily Gleaner.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
________________
The Royal Gazette — June 29, 2011 780 Gazette royale — 29 juin 2011
To: David Robin Oliver, of Sainte-Anne-de-Kent, in the Countyof Kent and Province of New Brunswick, Mortgagor;
And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 548 Perry Road,Sainte-Anne-de-Kent, in the County of Kent and Province ofNew Brunswick, PID Numbers 25294323 and 25072497.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 18th day of August, 2011, at 11:00 a.m., at the TownHall in Bouctouche, 211 Irving Boulevard, Bouctouche, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada
________________
TO: Julie Lynn Cyr, of Garnett Settlement, in the County ofSaint John and Province of New Brunswick, Mortgagor;
AND TO: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 18 White Road,Garnett Settlement, in the County of Saint John, and Provinceof New Brunswick, also known as PID No. 00471763.Notice of Sale given by New Brunswick Housing Corporation,holder of the first mortgage.Sale on the 13th day of July, 2011, at 10:30 a.m., at the CourtHouse, 22 Sydney Street, Saint John, New Brunswick. TheMortgagee reserves the right to postpone or reschedule the timeand date of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.
Gauthier & Associates, Solicitors for the Mortgagee, NewBrunswick Housing Corporation
The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:
Notice to Advertisers
Destinataire : David Robin Oliver, de Sainte-Anne-de-Kent,comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hy-pothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 548, chemin Perry, Sainte-Anne-de-Kent, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, etdont les NID sont 25294323 et 25072497.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 18 août 2011, à 11 h, à l’hôtel de ville deBouctouche, 211, boulevard Irving, Bouctouche (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada
________________
DESTINATAIRES : Julie Lynn Cyr, de Garnett Settlement,comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, débi-trice hypothécaire;ET tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 18, chemin White, GarnettSettlement, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 00471763.Avis de vente donné par la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, titulaire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 13 juillet 2011, à 10 h 30, au palais de jus-tice, 22, rue Sydney, Saint John (Nouveau-Brunswick). Lacréancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date etl’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-Journal.
Gauthier & Associates, avocats de la créancière hypothécaire, laSociété d’habitation du Nouveau-Brunswick
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette — June 29, 2011 781 Gazette royale — 29 juin 2011
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.
The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.
Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117
P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]
NoticesCost perInsertion
Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill
$ 20
Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission
$ 20
Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct
$ 25
Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act
$ 20
Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
$120
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)
$ 20
Notice of a correction charge isthe same as
for publishing the original document
Any other document $3.50 for each cm or less
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.
Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117
C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899
Courriel : [email protected]
AvisCoût par parution
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé
20 $
Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau
20 $
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés
25 $
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le
financement de l’activité politique20 $
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions
20 $
Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po
120 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur
20 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur
75 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)
20 $
Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés
pour la publication du
document original
Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou
moins
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés