the royal gazette / gazette royale (12/02/22)sachez que le directeur, en application de la loi sur...

30
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 170 Wednesday, February 22, 2012 / Le mercredi 22 février 2012 291 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin- ciales Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivan- tes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou docu- ments requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la pu- blication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites corporations. Loi sur les corporations commerciales Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to cancel the registration of extra-provincial corporations Notice of decision to dissolve provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to dissolve the following corporations pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents re- quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the corporations. Business Corporations Act

Upload: others

Post on 23-Apr-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 170 Wednesday, February 22, 2012 / Le mercredi 22 février 2012 291

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialeset d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-ciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivan-tes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporationsont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou docu-ments requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la pu-blication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourradissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and tocancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve thecorporations.

Business Corporations Act

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 292 Gazette royale — 22 février 2012

001391 001391 N.B. LTD.038942 038942 N.B. LTD.044089 044089 N.-B. LTEE049322 049322 N.B. LTEE/LTD056706 056706 N.-B. LTEE059477 059477 N.-B. INC.059744 059744 N.B. LTD.059754 059754 N.B. INC.501733 501733 N.B. LTD.503510 503510 N.B. LTD.504286 504286 NB INC506552 506552 N.B. INC.506590 506590 N.B. LTD.508722 508722 N.B. LTD.508864 508864 NB Ltd.508894 508894 N.B. LTD.508917 508917 N.B. INC.514004 514004 N. B. Ltd.514065 514065 N.B. Ltd.514083 514083 N.B. Inc.600312 516355 N.B. LTD.604255 604255 N.B. Ltd.605789 605789 N.B. Inc.611688 611688 N.B. Ltd.624417 624417 NB Corp./ 624417 N.-B. Corp.624457 624457 N.B. Ltd.630618 630618 NB INC.630640 630640 NB Ltd.630673 630673 N.B. Ltd.630674 630674 N.B. Ltd.630736 630736 N.-B. Ltée630952 630952 N.B. Inc.636307 636307 NB LTD637011 637011 N.B. Ltd.637069 637069 NB Inc.637115 637115 N.B. Inc.637144 637144 N.B. Ltd.637164 637164 N.B. INC.637192 637192 NB INC.637428 637428 NB Inc.643297 643297 N.B. Inc.643314 643314 NB Inc.643322 643322 N.B. Ltd.643533 643533 New Brunswick Corporation643584 643584 New Brunswick Ltd.643619 643619 NB Inc.643643 643643 NB LTD.649325 649325 NB LTD.649677 649677 NB Ltd.649679 649679 N.B. Ltd.649681 649681 N.B. Inc.649719 649719 N.B. Inc.649761 649761 N.B. Ltd.649778 649778 N.B. Ltd.649789 649789 N.B. LTD.649808 649808 N.B. Inc.649810 649810 N.-B. Inc.649811 649811 NB Inc.649812 649812 N.B. Inc.649821 649821 N.-B. Corp.649858 649858 N.B. Ltd.649886 649886 NB INC.649912 649912 NB LIMITED649972 649972 NB Inc.649975 649975 NB Ltd.650076 650076 NB Inc.650086 650086 N.B. INC.650089 650089 N.B. LTD.650100 650100 N.B. Ltd.650139 650139 N.B. Inc.650148 650148 NB INC.650163 650163 N.B. Ltd.650210 650210 NB Ltée 650210 NB Ltd.044160 A & M HOLDINGS INC.649801 Abdullah Alsaghir M.D. Professional

Corporation617566 ABER INDUSTRIES INC.636995 Abiron Enterprises Ltd.059620 ABOVO CONSTRUCTION INC.

617441 ACADIAN STURGEON AND CAVIAR INC.

649690 Accent International Inc.649614 ACR Framing Ltd.048730 ADAM CANADA LTD.650207 AER Industries Inc.000086 AHE PLUMBING & HEATING LTD.516334 AKITA (NB) BASEMENT SYSTEMS

INC637068 ALG Holdings Ltd.630573 ALIGN PEOPLE RESOURCES LTD.506675 ALL NIGHT ALL DAY INC.643427 ALL SEA ATLANTIC LTD.637184 ALREADY RITCHIE PROPERTIES

LTD.624542 Altimed Auto Repair Ltd630693 AMEYA INTERNATIONAL INC.047016 AQUILA TECHNOLOGIES INC.637142 AR.RO Realty Inc.039104 ATLANTIC CANADIANS HOCKEY

CLUB INC./CLUB DE HOCKEY CANADIENS DE L’ATLANTIQUE INC.

511510 ATLANTIC FORESTRY SERVICES LTD.

511550 AUBE’S FOODS LTD.511472 Audfroid Consultants Ltd.650167 Ava Capital Markets Canada Ltd.649758 AVALIS SOLUTIONS LTD.643692 Avatar Human Resources Consulting Ltd.643353 Azure Sky Films Inc.624448 B & M Specialized Automotive Services

Inc.650103 B.A.D.A.S. HOLDINGS INC.643805 BART GORMAN ENTERPRISES LTD.051510 BARTHOLOMEW ENTERPRISES INC.508907 BAYSIDE BULK TERMINAL

CORPORATION001613 BAYSIDE STEVEDORING LTD.649855 Benji Hawkes Drywall & Crackfill Ltd.617904 BETCO HAULAGE LTD.033450 BIRD’S CORNER STORE LTD.033335 BOUCHARD & FRERES

CONSTRUCTION LTEE506624 BRIKSON COMPUTER CABLING

LTD.637195 BROOKS HOMES LTD.643441 BRUNO ARSENEAU LIVRAISON INC.036919 BRUNSWICK ASSOCIATES LTD.002648 C. & D. CONSTRUCTION LIMITED617486 C. A. Crawford Insurance Inc.649892 Callstar Marketing Ltd.650085 Cambridge Equipment Corp.649783 Camp à Joe inc.504365 CAPE HOG FARM INC.044500 CARCROFT HOLDINGS INC.649889 Cardwell Compost (Asia) Inc.636941 Carleton International Ltd630875 Carleton Listings Inc.511608 CASTLEHILL PROPERTY

MANAGEMENT LTD.600168 CENTRAL SIDING LTD.003442 CHALEUR VIEW FARM SYNDICATE

LTD.031645 CHAMCOOK ASSOCIATES LTD.650078 Chameleon Electronic Security Inc.059604 CHANCE HARBOUR AQUACULTURE

AND FISHERIES INC.502004 CHAUSSURES JOCELYNE LTEE.649745 CHDM - Oil Canada Inc.506711 CHERISHED PET MEMORIAL

SERVICES LTD.501800 CHIASSON AQUACULTURE LTEE043445 CHIASSON MEUBLES MODERNES

LTEE051610 CHIPPIN & DEWITT ASSOCIATES,

INC.003818 CLOVER CONSTRUCTION LTD.003950 COATES AND HAINES LTD.

649860 Community First Funeral Home Inc.046418 COMPASS MARINE LIMITED504302 COOL SIDE REFRIGERATION LTD.514041 CORPORATE HEROES

INTERNATIONAL INC.636943 CSLB Holdings Ltd.053793 CURRY COVE SALMON LTD.649864 D & C Salvage Ltd.624606 Dan Guimond Auto Sales Inc650028 DCAM Productions Ltd.511533 DEBORAH O’LEARY, M.D.

PROFESSIONAL CORPORATION605626 Delphinium Ltée650105 Delta Light Canada Inc.649734 DeLuca Corp.502024 DEPANNEUR CHEZ RACHEL LTEE617754 DEVELOPMENTBOX INC.624582 DION-MAHANEY DRYWALL NB

LTD.514052 DOUBLE R FISHERIES LTD.643292 DR. AKMAL GHAFOOR

PROFESSIONAL CORPORATION643828 Dr. German W. Blando cp inc.605564 DR. GILBERT DRU CORPORATION

PROFESSIONNELLE INC.630669 Dr. J. J. Morales Professional Corporation049441 DR. J.C.W. PARROTT PROFESSIONAL

CORPORATION605879 Dr. Jean-François Guité Corporation

Professionnelle Inc.514135 DR. RONALD HAREBOTTLE PROF.

CORP.637064 DR. SYED AHMED & DR. NAJNEEN

AHMED PROF. CORP.643298 DREAM MAKERS RECREATION INC.637112 DURELLE’S PEST MANAGEMENT

LTD.649646 Durrani & Webb Holdings Ltd649954 ECKO SOLUTION PLUS INC.624503 Entreprise C.D.G.M. Enterprise Inc.008636 EPICERIE R.H. CLAVETTE INC.643508 EXCELL PERMITS & PILOT

VEHICLES LTD.508881 Exigen (Canada), Inc.624383 FAUNE HERITAGE WILDLIFE INC.643882 FOAM FREE DRAUGHT EXPERTS

INC.504403 FORESTERIE G.L. INC.630968 Foresterie Robichaud Inc.611471 Fundy Minerals Ltd643320 Future Metal Roofing Inc.059607 G. BOUDREAU HOLDING INC.643277 G. Bourque Deliveries Ltd.047076 G. S. MACDIARMID PROFESSIONAL

CORPORATION511498 G.G. VENTURES LTD.617608 G.G.Y. Trucking Ltd.617473 G.K. HOLDINGS LTD.605985 Garage Laurie Inc.643497 GARTH POWER TRUCKING LTD.501957 GEO-MAR INC.501958 GEORGE T. YEAMANS

PROFESSIONAL CORPORATION INC.

007081 GESTION ACADIENNE LTEE - ACADIAN MANAGEMENT LTD

617664 Gestion YR Ltée630545 GOLBAD DISTRIBUTION SERVICES

LTD637196 Gold Sun Media Inc.611716 Golf 101 Inc.630656 Gordon Sharpe Enterprises Inc.059816 GREAT CIRCLE MARINE SERVICES

INC.059666 GREEN SHORES ESTATES INC.650054 Green Water Diving Inc.051616 GTA CONSULTANTS INC.611579 GUYCHEM INC.624510 Hansen International Inc

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 293 Gazette royale — 22 février 2012

649630 HFHG Consulting Inc.053811 HIGGINS GENERAL INSURANCE

LTD.053780 HILLDALE POTATO INC.031608 HORIZON ENTERPRISES LTD.649820 Hotchkiss Home Furnishings Ltd.617447 Howard Brook Development Inc.008236 HOYT’S SEPTIC SERVICES LTD.008237 HOYT’S SUPERMART LTD.650075 HRMS Solutions, Inc.617505 HYDRO CLEAN INC.611556 I.M.S.G. INFORMATION

MANAGEMENT SYSTEMS GROUP INC.

649750 IMT Training Services Inc.630720 Inevitable Holdings Corp.649844 INFORMATICS TERAFLOP CENTRAL

INC.631002 Ingallwood Manufacturing Inc611211 InteliConnect Ltd.650023 Iron Hill Holdings Ltd.643394 IT Equipment Xpress Ltd.649615 J & L ENERGY INC.031681 J. E. & R. GODIN & FILS LIMITEE630861 J.A.L. Janitorial Ltd.649779 JACKY’S BAR INC.637424 Janus Project Management Services Ltd.059727 JARROSS INVESTMENTS LTD.630797 JEANNINE & ROBERT TOURS INC.611560 Jeremiah Jacobs Ltd.643285 JJL HOLDING INC.611646 John D. Boyd Plumbing & Heating Ltd.053763 JOS S. LEGER & SON TRUCKING

LTD.637235 Joshua Investments Inc.511476 JPM ENTERPRISES INC.630686 JSM HOLDINGS INC.051576 JW Walsh & Son Transportation Services

Inc.013256 K. W. POND LIMITED514115 K.C. HOWE HOLDINGS LTD.600074 KA KA GOOSE INC.605853 KATERA INDUSTRIES INC.643295 Kings Point Productions Inc.611472 KNOWLEDGE ATLAS INC.508895 KRISHNA SAI INC.649743 KVT TRUCKING INC.009472 LAIRD’S CONSTRUCTION LTD.049471 LAM & ASSOCIATES LIMITED643444 Lan-Bert Homes Development Ltd.630949 Land and Sea Training Ltd.511479 LATIF PIZZA & DONAIR LTD.513202 Les Entreprises R.E.H. Fournier Ltée013382 LES PRODUCTEURS D’ARBRES DE

NOEL CLAIRE-FONTAINE LTEE.642921 LL BRANCH CONSULTANTS INC.624193 Logroty Inc.049480 LOSIER STATION SERVICE LTEE056766 LOUMAREX INC.508850 M & W CONTRACTING LTD.649963 M. J. Roy Foundation NB Inc.617663 M.S.T. Consulting Inc.010254 MABIE INVESTMENTS LTD.637154 MacLeod Agronomics Ltd.036961 MAK BROTHERS LTD.650209 MakCass Management Inc.643737 Marathon Canada Imports Ltd.010443 MARCHE B. PAULIN LTEE036897 MARIETTE ENTREPRISES LTEE051625 MARITIME WATER TREATMENT

LTD.

624413 Maritime Window Defogger Inc.639773 MaRusCo Enterprise Ltd.059499 MATHIS INSTRUMENTS LTD.011777 MCLEAN’S AUTOMOTIVE LTD.010838 MELANSON PLUMBING & HEATING

LTD.650102 Mereah Land Services Ltd.038618 METRO PROCESS SERVERS LTD.617966 MICHAUD HOLDINGS (2005) LTD624279 MICHEL BERUBE FORESTRY INC.600260 MIKKEMA INTERNATIONAL INC.030237 MIRAMICHI FOREST ENTERPRISES

LTD.041451 MIRAMICHI TAVERN & CLUB LTD.617474 MISTER RENOVATIONS LTD.637328 MITCHCO WELDING &

CONTRACTING INC.600242 Modern Masonry Inc.511467 MOE’S ELECTRIC LTD.011319 MONCTON UNION CENTRE LTD.650142 MSP Drywall Ltée511404 MSSI HOLDINGS INC.637357 Muir Bros. Services Ltd.502019 N.R. HOLDINGS LIMITED630676 New Age Glass Repair Inc.504270 NEWMAN & CO. INC.513941 NORTH STAR HOLDINGS LTD.637362 NORTHUMBERLAND WOODLOT

ENTERPRISES INC.514029 OCEAN LEGACY INC.649754 On The Way Gifts & Things Inc.012798 PARK CHEDIK LTD.-PARC CHEDIK

LTEE053761 PASSEKEAG PHEASANTS LTD.649732 Perkfection Coffee Ltd.649605 PES Parking Enforcement Solutions Inc.511366 PHYSIO PÉNINSULE INC.650108 PIBM Renovations Inc.649645 PIRET (EDMONTON AVENUE)

LEASEHOLD INC.649644 PIRET (NB) HOLDINGS INC.059763 PLASTER ROCK GYPSUM &

MANUFACTURING LTD.508985 POINTE-SAPIN AUTO PARTS LTD./

PIECES D’AUTO POINTE-SAPIN LTEE

013311 PRECISE SURVEYS LTD.036998 PRECISION EDGE LTD.649152 PREFERRED PAVING AND

CONSTRUCTION (2010) LTD.624391 Pro Edge Sports Moncton Ltd.611525 QUACO DUCK FISHERIES LTD.013518 QUALITY SOUND ALARM LTD.637262 R & B Watch & Jewellery Ltd.611417 R YOUNG INDUSTRIAL LIMITED650144 R. Boudreau Tree Trimming Ltd605855 R.L.M. Fisheries Ltd.041653 R.M. WATSON AGRI-CONSULTING

LTD.617461 Rebound Holdings Ltd.637122 Remorquage Edmundston Towing Inc.508956 Resto Grec Inc643733 RESTO-BAR LE DECK INC.643756 Richard Development Consulting Inc.013979 RICHARD FARMS LIMITED046956 RIDELL HOLDINGS LTD.014025 RIDGEVIEW ENTERPRISES LTD.014029 RIDGEWOOD FARMS LIMITED014144 RIVIERA CONSTRUCTION LTD./

RIVIERA CONSTRUCTION LTEE650088 S&S LANDSCAPING LTD.

053671 S. & L. REALTY 2000 INC.624463 Saint John Marketers Group Inc.514151 ScarHawk Industries Ltd.014855 SCORPIO INVESTMENTS LTD.030213 Sea-Post Ltd.643570 SHUR-LOCK PARKING AUTHORITY

INC.636990 SHUR-WAY INVESTMENTS INC.630853 Silver Maple Developments Inc.624665 SOCIÉTÉ STÉPHANE LOSIER INC.015383 SOUTH BRANCH OROMOCTO LTD.630816 SOUTH DAKOTA URANIUM, INC.624254 SOUTHSIDE MANAGEMENT INC.649830 Speckled Springs Trout Farm Inc.617977 SPRUCEHILL ENTERPRISES LTD.611262 ST-ISIDORE RIDO-DECO LTÉE049110 ST. ANDRE FARMS LTD.044468 St. Ignace Wood Truss Ltd.031651 STAR KEY ENTERPRISES LTD.611398 STEELE VENTURES INC.611229 Sugar House Inc.516313 SULLIVAN LANE FARM LTD.053668 SUPERIOR CONCRETE FINISHING

LTD.650160 T & C DUNPHY CONTRACTING LTD.511512 T M T Stable Inc.637062 T-Riple J Holdco Ltd.650196 T.E.R Consulting Inc.504424 TANYA GAYLE ESTATES LTD.649961 THE EMPEROR’S KITCHEN INC.650106 The Finish Guy Inc.508943 The Fishermen’s Anchor Inc.617945 The Gallagher Pub Group Inc.046719 THE KILLAM AGENCY INC.650161 The Reel Review Inc.611410 THE RESULTS COMPANY INC.016118 THERMOFIB LTD./ LTEE605644 THREE GZ INC.624543 THRIFTKING GROUP INC.059750 TONY’S SERVICE STATION (1995)

LTD.643480 TOPdesk Canada Corporation514227 Turn of the Century Trolley Tours Inc.030198 U. S. L. RESTORATIONS LTD.649672 Unique Landscaping and Property

Management INC.605754 URBAN CONSTRUCTION ATLANTIC

LIMITED605753 URBAN DEVELOPMENTS ATLANTIC

LIMITED643397 Vanguard Studio Inc.649948 VAPOR GREEN SOLUTION LTD /

SOLUTION VAPEUR VERTE LTEE038919 VICKERS POOLS LTD.611643 VISTA BAY MOTORS INC.059521 VU TRUONG RESTAURANT LTD.001633 W. J. BEAIRSTO CO. LTD.611689 W. J. INDUSTRIAL SALES INC.649699 WAKEFORD BUSINESS LTD.649647 Webb & Durrani Holdings Ltd617470 Wee World Inc.649828 WENDOW CORP.624500 West Side Service Center Ltd.643845 Westgate Financial Group Inc.624551 Winchester’s Classic Woman Limited637138 With Power Property Holdings Inc.611393 Wow Now Inc.021434 YOUR CANDLE SHOP LTD.

_____________________________________________________

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 294 Gazette royale — 22 février 2012

624248 2051099 ONTARIO INC.637182 3101-5837 QUÉBEC INC.636929 6880061 Canada Ltd.073162 ACME TRUCK LINE, INC.649691 AFS Aerial Photography Inc.649752 AIB INTERNATIONAL CANADA, INC.649843 ATLANTIC CANADA HVAC

SERVICES INC.643751 Atlantic Medical Imaging Services Inc.624155 BEN LIVINGSTON AND SONS

LIMITED077585 Bristol Group Inc.018966 BUTLER TRUCKING COMPANY077130 COMCARE (CANADA) LIMITED647757 CRS Civilian Regulatory Specialists Inc. /

CRS Spécialistes Réglementaires Civil Inc.

650172 efo Capital Inc.650079 ÉRABLIÈRE LUC ET CRAIG

GAGNON INC605874 Evans Land Development Limited600348 FRIENDS OF THE FAMILY ESTATE

SERVICES INC.624274 INTERNATIONAL MUFFLER

COMPANY074556 JEUNIQUE INTERNATIONAL

(CANADA) INC.600542 LASANALTECH INC.649686 LORBEC METALS LTD. / MÉTAUX

LORBEC LTÉE649635 M & C HESSE TRUCKING LIMITED076258 MCKEIL MARINE LIMITED077123 NEWS MARKETING CANADA CORP.636628 Peake & McInnis Ltd.

643154 PRO FORÊT EXCELLENCE INC.624123 Q1 Labs, Inc.611594 REGAL-BELOIT HOLDINGS LTD.650188 Reinhausen Canada Inc.649602 Shred-it International Inc.647445 Superior Kitchen Designs, Inc.073658 TRUSERV CANADA INC.076658 Tulsa Inc.649819 TUMBLEWIRE INC.650081 WELLINGTON WEST CAPITAL

MARKETS INC.

022317 58 LEGION COURT INC.000701 ARGOSY PUBLICATIONS INC.023051 ASSEMBLIES OF THE LORD JESUS

CHRIST OF NEW BRUNSWICK INC.624320 ASSOCIATION DES FAMILLES

THÉRIAULT DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

643839 Atlantic Fermenters Association Inc.605740 BATHURST SUPERIOR CAFETERIAS

INC.024153 BELLEDUNE RIVER CEMETERY INC.023681 BELLEISLE VALLEY

RECREATIONAL ASSOCIATION INC.

002919 CANADIAN FORESTRY ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK, INC.

003274 CENTRAL NEW BRUNSWICK WOODMEN’S MUSEUM INC.

003304 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DIEPPE INC.

003313 CENTRE CULTUREL D’ALLARDVILLE INC.

023117 CLUB DE CURLING TRACADIE-SHEILA INC.

013318 CLUB RICHELIEU FREDERICTON INC.

636921 Community Homeless Network Inc. / Réseau communautaire des Sans abri. Inc.

025087 COMPASSION SERVICES OF CANADA, INC.

004441 COVENANT REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF NEWCASTLE INC.

600004 DOUGLASTOWN COMMUNITY CHURCH INC.

023891 FUNDY TRAILRIDERS ATV & SNOWMOBILE CLUB INC.

024908 GRACE BAPTIST CHURCH (INDEPENDENT) OF MONCTON, INC.

650175 HAVELOCK HORIZONS INC.624423 HOPE PARTNERS INTERNATIONAL

INC.600007 Impossible Realities Inc.008465 INKERMAN RECREATION COUNCIL

INC./CONSEIL RECREATIF D’INKERMAN INC.

008714 JACQUET RIVER LIONS CLUB INC.605759 KENNEBECASIS VALLEY -

COMMUNITY - CAPACITY - CHILDREN INC.

023427 KINETTE CLUB OF THE MIRAMICHI INC.

024364 L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU CENTRE D’EXCELLENCE DU TOURISME DE L’ATLANTIQUE (AE-CETA) LTÉE

643326 LA MAISON DE LA FAMILLE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE INC.

636863 La Solitude de Pré-d’en-Haut Inc.021803 LEAF TRAILS INC.022314 LES RESIDENCES DE LA

REPUBLIQUE INC.022532 Ligne Téléphonique C.A.R.A. Help Line

Inc.022879 METRO HEALTH SERVICES INC.025580 MIRAMICHI JUNIOR “A” HOCKEY

CLUB INC.609070 New Bandon/Salmon Beach Social

Committee Inc.025582 NEW BRUNSWICK ANTI-POVERTY

LEGAL CLINIC INC.021821 NEW BRUNSWICK LIBRARY

TRUSTEES’ ASSOCIATION INC./L’ASSOCIATION DES COMMISSAIRES DE BIBLIOTHEQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, asthe said corporations have been in default in sending to the Directorfees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, theDirector may cancel the registration.

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir auDirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans laGazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desditescorporations extraprovinciales.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provincialesSoyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa-gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertude l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publicationdu présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudrelesdites compagnies.

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companiesTake notice that the Director under the Companies Act has made a de-cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.Please note that 60 days after the date of publication of this Notice inThe Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Companies Act

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 295 Gazette royale — 22 février 2012

012138 NEW DENMARK HISTORICAL SOCIETY INC.

024906 NEW DENMARK SENIORS’ COMPLEX INC.

600003 Northside Youth Centre Inc.024716 OPERA NEW BRUNSWICK INC.024162 PLACE HISTORIQUE DU

MADAWASKA INC600000 Purdy’s Corner Townhouse Association

Inc.023400 RENOUS KNIGHTS CHARITIES INC.014009 RICHIBUCTO LIONS CLUB INC.022107 ROTARY CLUB OF BATHURST

CHARITY FUND INC.

022101 ROTARY CLUB OF GAGETOWN, NEW BRUNSWICK, INC.

018323 ROYAL CANADIAN LEGION MONCTON # 6

014993 SENIOR CITIZENS SERVICES SAINT JOHN INC.

025706 SHEDIAC BAY WATERSHED ASSOCIATION INC./L’Association du bassin versant de la baie de SHEDIAC Inc.

611356 Silicon East Inc.643713 St. Joseph’s Hospital Auxiliary Inc.022556 THE CHALEUR GROUND SEARCH

AND RESCUE TEAM INC.617472 THE JOSHUA EVANS’ TRUST INC.

011864 THE N. B. I. P. CO. EMPLOYEES’ ASSOCIATION INC.

015954 THE TABUSINTAC CLUB, LIMITED637023 Victoria Park Enhancement Committee

2008 inc.025715 VICTORIAN ORDER OF NURSES

CANADA NEW BRUNSWICK BRANCH INC.

016766 VICTORIAN ORDER OF NURSES, (MONCTON BRANCH), INC.

624535 VICTORY LIGHTHOUSE INC.016974 WAUKLEHEGAN MANOR INC.650112 Western Valley Adult Learning

Association Inc.

629575 Barb’s B & B629886 BLACK BOWSER COMICS629781 Fortune Market629176 KC Solid Surface629208 MARK’S STEAM CLEAN351048 Mountain View A.T.V. Outdoor

Adventures

629656 RaJe Informatik628854 Rejuvinate Spa348436 RoMar REAL ESTATE MANAGEMENT629426 ScrapAway629497 SHALLAN & SARA MESSAGE IN A

BAG629285 SHELL CANADA ENERGY

350821 SHELL CANADA PRODUCTS/PRODUITS SHELL CANADA

629818 Staged Designs629661 TARGET MAGAZINE338086 TRIPLE F RANCH

629990 (KCMS) Key Concepts Management Systems

629588 ACADIAN RIM RECYCLING629736 AFS Leasing629645 AfterImage New Media629976 AKELA Canoes629903 ALBA TOURS348469 Alliance Flow Products340870 ALPHAPLEX CUSTOM

FABRICATION629904 ALUMNI HOLIDAYS353107 AMBER STAINED GLASS

629345 Atlantic Mobility Products610529 Atlantic Towing / Kent Line Operations629784 ATTKINS SOUL629734 Auto Sales Unlimited629706 Auto Stream629662 Avenue Appliances629989 AVENUE MOTORSPORTS629468 Bathurst Mortgage Center/Centre

Hypothécaire Bathurst629805 Bennett Occupational Therapy629635 Bernie’s Auto Cure629601 Blue Backyard Consulting

629571 BMC GROUP629512 Brad LeBlanc Enterprises629951 Brafasco628857 BRAKEWHEEL PRODUCTS629612 Bravurin Technologies335311 BRUNSWICK LOAN ACCEPTANCE629682 C.P. COMPUTER DOCTOR629658 Cabinet Kevin J. Haché628288 Cafe-Bistro Mon Ami630000 Canada St. Variety629691 Canadian Green Products629839 Capital ADvice Advertising

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, envertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétésen nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificatsd’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé defaire enregistrer des certificats de renouvellement conformément àl’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selonle cas.

SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registrairepeut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nomcollectif et certificats d’appellations commerciales.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of thecertificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-nexed hereto and the certificates of business names of the businessesset forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the saidfirms and businesses have failed to register certificates of renewal inaccordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),as the case may be applicable, of the said Act.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date ofthirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-trar may cancel the registration of the said certificates of partnershipsand certificates of business names.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 296 Gazette royale — 22 février 2012

348539 CAPITAL PEST CONTROL629905 CARRIES TRAVEL INTERNATIONAL629992 CHÂTEAU ROYAL: CENTRE DE

VILLÉGIATURE FAMILIAL629993 CHÂTEAU ROYALE: A FAMILY

RESORT330358 CHINA COAST350863 Claremont Communications351049 Clinique de Massothérapie de Shédiac

Shediac Massage Therapy Clinic348530 Cobalt60 Design & Graphics629549 Coiffure Esthetique Sylvie Drouin629578 COLLETTE CONSULTANT629970 COMMUNICATIONS COURT-

CIRCUIT - SHORT CIRCUIT COMMUNICATIONS

629506 Confident Solutions629586 COOPER FRIDAY’S629959 COUNTRY ROADS CIDER C0.353143 COURTENAY INSURANCE AGENCY629906 CRONOS TRAVELPLAN629907 CRUISEESCAPES629769 Dabest IT Consulting348496 DAVE BALDWIN AUTO SALES350993 DEBI’S HAIRDRESSING 1409629752 Decorating Dimensions350907 Decorative Treasures629895 Déja vu Second Hand Store350894 DÉJÀ-VU SIGNS ETC.348590 DENTS BE GONE348531 DIANE TERRY, MASSAGE THERAPY629611 DLA Sales & Marketing629463 DNR Jewellery Exchange629657 DOMAINE DE LA VALLÉE DE LAC-

BAKER629458 DPT SECURITY629550 East Coast Automotive Warehousing348429 Edward Hanselpacker Auto Repair629852 Elbow Grease Welding337839 EMPIRE ELECTRIC629812 Ethnic Rainbows Native Cast319479 EVERY THING WE TOUCH TURNS

TO SOLD629825 Evolution Stone Works353231 FARRELL ENVIRONMENTAL

SYSTEMS629871 FIRE READY EXTINGUISHER SALES

& SERVICE348395 FOREMOST INSURANCE350881 FROG’S PAD629459 FTI Group629633 Fundy Alternative Power627708 Garderie Chez Catherine629543 Gladstone Alpacas350663 Gleason Arms629742 GORDIE’S PUB629730 Gould’s RenoScaping629949 Grafton Utility Supply629953 Grafton Utility Supply (Western)629950 Grafton West629584 GULLISON’S COURIER SERVICE629465 Haddad Marketing629718 Happy and Healthy Products for Mind,

Body and Soul316673 HARRIS REBAR629610 Harvest Moon Soap629941 HD Supply629942 HD Supply Canada629946 HD Supply Electrical629943 HD Supply Facilities Maintenance629952 HD Supply Fasteners & Tools629948 HD Supply Utilities629449 Hoffmann Design629793 HOUSE OF TUDOR350990 HUBCAP COMEDY FESTIVAL DE

L’HUMOUR

629749 HURON DUST CONTROL629748 HURON MATS RENTALS629527 IMAGINiT Technologies629675 Independent Ironworks629764 INDOR MFG.629614 Inner Beauty Esthetics629704 Innovative Interpretations Hospitality

Consulting629668 InsTint Window Tinting629597 J.R. LIQUIDATORS629833 JAGUAR CREDIT CANADA LEASING353261 JC Linder Ventures629789 Jeff Bonnar & Son Renovators629616 JFR Communications348405 Julie’s Beau-T Stop629595 Kelly’s Travel And Tours629644 KGM Roofing and Home Improvement350879 KILLAMS WELDING & MACHINING629790 Knotty Girl Fibre Arts629686 KOVACK TREE SERVICES629674 KUTZ FOR MEN629690 KYLE BROWN MEMORIAL FUND350914 L.M.A.C. GOBI629834 LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

LEASING629846 Laundromat Espresso Bar629735 Lavender Lane Cottage629900 LEELAND TRUCK & EQUIPMENT

SALES629689 Lemon Tree Gifts and Crafts629826 Liberty Alliance629775 LITEMOR629945 Litemor Distributors629596 Little Acorns629478 LITTLE JOHN’S VARIETY629977 LJW Choice Consulting629581 Local Moving & Storage629338 Location Crédit Jaguar Canada629340 Location Crédit Mazda Canada629339 Location Services financiers Land Rover629519 Lynch’s Accounting Service629751 Lynne Breen Photography629698 M. P. Creations350903 MAJESTIC JUICES346046 Maliseet Smoke Shop629750 MARCHE INKERMAN ENRG.629680 Marilyn Bustard, Custom Sewing629897 MARINER’S REACH629795 Maritime Precision Industries353280 MARLOG CONSULTING629688 MASCARET MEDIA629995 Master CopyCats629667 Mathis Consultants629797 McDonough Bros. Landscaping629104 Melda’s Art Shop629490 Melvin’s Cafeteria629712 Mike Gould Enterprises350935 MIRAMICHI UNIQUE UNIFORMS629498 MONEY IN YOUR POCKET DEPOT629891 Musée de la Bière629554 My Super Vacations629910 MYALBATOURS629911 MYENCORE CRUISES629912 MYHOLIDAY HOUSE629913 MYNETWORK629914 MYSUNQUEST629916 MYTOURS MAISON629915 MYTRAVEL CRONOS TRAVELPLAN629917 NETWORK INTERNATIONAL

AIRFARES629880 NEW WAY MOVING AND STORAGE314566 NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF

ANGLERS AND HUNTERS314567 NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF

HUNTERS

314568 NEW BRUNSWICK FISH AND GAME ASSOCIATION

629994 New England Pizza Company629460 NEWAY MOVING & STORAGE629779 NIGHT SHIFT JANITORIAL350912 Northumberland Funeral Home351034 Old English Motorcycles352785 Paige One Enterprises628820 Pauley & Sons Sales Agency623123 Pêcheries F.N.353200 PENTARUS GRAPHICS353279 PFC CONSULTING629771 Phillips Security Personnel348127 PL Digital Informatique & Satellite Enr.629660 PORCUPINE KING629935 POTATO INTERNATIONAL353197 Pro-Tect Installers629515 R & R Auto Clinic353194 R.D.C. SPORT629504 Randy’s Tickle Trunk629975 RE/MAX GROUP FOUR REALTY629613 Red Pines Art Studio629711 Red Wave Solutions629598 REMEMBER MONCTON OU VENIR629858 RENT-A-MAN350938 RICHARD BOOKKEEPING350943 Richard Marine Sales and Service629968 RIVER VALLEY FIRE CONSULTING629753 Rogersville Cafe348582 SAMUEL DOW EXPLOSIVE

ORDANANCE DISPOSAL CONSULTANT

629997 Saulnier Maintenance629679 SCHLUMBERGER ARTIFICIAL LIFT629482 SCHLUMBERGER COMPLETIONS629479 SCHLUMBERGER TESTING629813 Sensabella Esthetics & Nail Studio629967 Sevans Small Business Consulting629714 Shear Clothing350964 SHIRETOWN STORAGE629901 SILI-CON LOGISTICS629919 SILVER FERN HOLIDAYS312336 SMITTY’S FAMILY RESTAURANT629604 Sneek A Peek Gifts629998 Snowbird Financial Services351021 Soudure Gravel & Fils Enr.629815 Steel In Time629485 Stewart Heavy Equipment Contracting &

Rentals629881 Style & Grace Pet Salon338034 SUCO BUSINESS SERVICES353252 Team Air Express353250 Team Customs Brokerage353251 Team Ocean Services353253 Team Worldwide629655 The Celestrial Soul Connection629579 The Colour Center629850 THE GOOD GUYS BREW SHOPPE629632 The Greens Condominium629944 The Home Depot Supply629609 The Mattress Medic629947 The Primitive Cellar312248 THE SONY STORE629924 THN EXPLORATIONS327956 TOUCH OF CLASS SERVICES629824 TRACY STARR629888 Transitions Co-Active Life Coaching629802 Trophy Safaris Int’l New Brunswick629547 U-Pedal Boats629965 Valley Restaurant629777 Vue à vol d’aigle350931 Wavetech Business Supplies629637 Whippowill Consulting & Sales629844 WORLD WINE AND FOOD EXPO629467 WWWA Wholesale

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 297 Gazette royale — 22 février 2012

661818 NB Ltd. New Line 661818 2012 01 26

661821 N.B. LTD. Saint John 661821 2012 01 26

Fine Art Collection Holdings Limited Saint John 661830 2012 01 26

661831 N.B. Inc. Oak Bay 661831 2012 01 27

Jean Léger & Son Contracting Inc. McKees Mills 661832 2012 01 27

Bound Communications Inc. Lower Woodstock 661833 2012 01 27

661836 NB LTD. 661836 NB LTEE Perth Andover 661836 2012 01 27

Maritime Daytripping Inc. Fredericton 661839 2012 01 27

MEGA CHAGA LTD. Riverview 661840 2012 01 27

661841 NB LTD. Richmond Corner 661841 2012 01 27

David Long Holdings Inc. Rothesay 661842 2012 01 27

G.P. APARTMENTS INC. Saint-Léonard 661843 2012 01 27

661845 N.-B. INC. Caraquet 661845 2012 01 27

661846 NB Ltd. Saint John 661846 2012 01 27

CAMERA CREW MEDIA PRODUCTION CORP. Moncton 661867 2012 01 27

661868 N.B. LTD. Grand-Sault / Grand Falls 661868 2012 01 28

Timoe Express Inc. Bouctouche 661869 2012 01 29

ElectroCore Canada, Inc. Saint John 661870 2012 01 30

661871 N.-B. CORP. Moncton 661871 2012 01 30

Northern Highlights Hair & Body Salon Ltd. Fredericton 661872 2012 01 30

KSK Holdings Inc. Moncton 661874 2012 01 30

Dent Pro Hail Repair Inc. Riverview 661880 2012 01 30

ROYAL ATLANTIC OYSTER INC. Saint-Louis 661881 2012 01 30

Saint John Early Childhood Centre Ltd. Saint John 661883 2012 01 30

TOBIQUE FARMS OPERATING (2012) LIMITED DSL de / LSD of Drummond 661889 2012 01 30

Fortin Construction (2012) Inc. Grand-Barachois 661891 2012 01 30

EXHALE YOGA BOUTIQUE INC. Campbellton 661892 2012 01 30

MSP Work Solutions Inc. / Solutions au travail MSP Inc. Moncton 661893 2012 01 30

MDS IGLASS INC. Moncton 661894 2012 01 30

K&W ENTERPRISES LTD. Apohaqui 661903 2012 01 31

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 298 Gazette royale — 22 février 2012

C. Scott Holdings Ltd. Saint John 661908 2012 01 31

661913 NB Inc. Moncton 661913 2012 01 31

TEC Encryption Technology Ltd. Shediac 661918 2012 01 31

Three Talons Investigations Ltd. Saint John 661921 2012 01 31

FREDDIE’S PIZZA LTD. Moncton 661923 2012 01 31

Sugarloaf Estates Inc. Moncton 661924 2012 01 31

Ryan Oak Estates Inc. Moncton 661927 2012 02 01

661928 N.B. INC. Riverview 661928 2012 02 01

DR. BRETT TREMBLE PROFESSIONAL CORPORATION Moncton 661929 2012 02 01

Coast Tire (Summerside) Ltd. Saint John 661939 2012 02 01

Brian Morin Construction Inc. Edmundston 661941 2012 02 01

Carter’s Cranberries Inc. Central Blissville 661942 2012 02 01

Chantal’s Steakhouse Inc. Saint-Joseph 661950 2012 02 02

Burke & Theriault Investments Ltd. Fredericton 661955 2012 02 02

TONA Holdings Ltd. Island View 661956 2012 02 02

MP Investments Corp. Island View 661957 2012 02 02

661958 N.B. Ltd. New Denmark 661958 2012 02 02

Gold Bar Development & Consulting Inc. Shediac 661965 2012 02 02

_____________________________________________________

661047 N.B. Inc. Saint John Canada 661047 2012 01 31

661048 N.B. Inc. Saint John Canada 661048 2012 01 31

661046 N.B. Inc. Saint John Canada 661808 2012 01 31

GREEN HAVEN MOBILE HOMES LIMITED Saint John Ontario 661811 2012 01 31

COWAN PLACE LIMITED Saint John Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

661812 2012 01 31

VOGUE HOLDINGS INC. Saint John Île-du-Prince-Édouard /Prince Edward Island

661930 2012 01 31

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 299 Gazette royale — 22 février 2012

GUIDOU ELECTRIC LTD. 007580 2012 01 31

J. L. SIMMS (’74) LTD. 015203 2012 01 30

CAJO MARTEL TRANSPORT LIMITEE 020201 2012 01 27

CLEARWATER WELL DRILLING (1983) LTD. 031695 2012 01 31

WALCOTT MACHINING AND FABRICATION LTD. 059792 2012 01 31

Fermes Semences Desjardins Seed Farms Ltd./Ltée 512472 2012 01 27

LITECO INC. 513882 2012 01 31

HARD ROCK DRILLING LTD. 606390 2012 01 27

I. GÉRALD LÉVESQUE CORPORATION PROFESSIONNELLE / I. GÉRALD LÉVESQUE PROFESSIONAL CORPORATION

608311 2012 01 31

635116 N.B. LTD. 635116 2012 01 31

JAKAS Holdings Inc. 635117 2012 01 31

SwiftRadius Inc. 635872 2012 01 31

BREWCO PLANNING INC. 642006 2012 02 01

661378 N.B. Ltd. 661378 2012 02 01

_____________________________________________________

QPS Canada Inc. Interactive Visualization Systems, Inc. 608306 2012 01 26

608667 NB Inc. EAST SIDE SPORTS INC. 608667 2012 01 26

CHARLES STREET FINANCIAL INC. Son Communications Inc. 617213 2012 01 31

Productions Siallam Inc. 644931 N.-B. Ltée 644931 2012 01 31

Phytoplankton Biotech Inc. Sackville Jam Shack Ltd. 653307 2012 01 31

654744 N.-B. INC. 654744 N.-B. INC. 654744 2012 01 31

Tri-Star Antimony Canada Inc. 656952 N.B. Inc. 656952 2012 01 27

658785 N.B. Inc. Maritime Fastening Systems (2011) Inc. 658785 2012 01 30

X & O HOLDINGS LTD. 659780 NB INC. 659780 2012 01 31

Westmorland Animal Hospital Inc. 660908 NB Inc. 660908 2012 01 25

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 300 Gazette royale — 22 février 2012

L.M.D. Holdings Ltd. L.M.D. HOLDINGS LTD.630921 N.B. Ltd.

Moncton 661715 2012 01 31

Stewie’s Lobsters Ltd. CHAOS FISHERIES LTD.STEWIE’S LOBSTERS LTD.

Alma 661779 2012 01 31

660551 NB LTD. 055720 N.B. LTD.660551 NB LTD.

Bath 661855 2012 02 01

LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.

CORLAND CONSTRUCTION INC.LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.

Dieppe 661859 2012 02 01

Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD Dermatolgue Inc.

A. BOLDUC, M.D., C.S.P.Q., F.R.C.P.(C),C.P. Inc.Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD Dermatologue Inc.

Moncton 661877 2012 02 01

628377 NB INC. 628377 NB INC.658580 NB LTD.

Fredericton 661905 2012 02 01

Liteco Inc. SJK HOLDINGS LTD.LITECO INC.R.G.M. INVESTMENTS (2006) INC.

Fredericton 661914 2012 02 01

049046 N.B. Ltd. 049046 N.B. LTD.CHIGNECTO ENTERPRISES LIMITEDLONAMY INC.

Upper Coverdale 661916 2012 02 01

Belmar Investments Limited Mejora Holdings LimitedBelmar Investments Limited

Woodstock 661945 2012 02 01

_____________________________________________________

GARAGE ST. PIERRE LTEE Kedgwick 006928 2012 01 19

NORTH SHORE ALARMS-HUDON’S SECURITY SERVICES CO. LTD.

Bathurst 032714 2012 01 30

Cebacob Holdings Ltd. Bocabec 033407 2012 01 26

CHARLES E. WILLIAMS & COMPANY LTD Grand Bay-Westfield 047441 2012 01 20

ENTREPRISE S.K. (1993) LTEE Kedgwick 053507 2012 01 19

SLEDS & TREADS LTD. Sussex 500742 2012 01 27

JOE’S WOODWORKING LTD. Fredericton 504033 2012 01 31

MOUNT MISERY HOLDINGS INC. Kingston 506518 2012 01 26

Anacomp Canada Inc. Saint John 604923 2012 01 25

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 301 Gazette royale — 22 février 2012

MHR HOLDING INC. Moncton 606039 2012 01 30

The Davis & Lee Financial Planning Centre Ltd. Rothesay 610535 2012 01 10

Kindred Sound Productions Inc Saint John 610814 2012 01 25

JD Vending Inc. Dieppe 622448 2012 01 26

Executive Auto Imports Ltd. Fredericton 633720 2012 01 26

Accurate Tax & Accounting Inc. Saint John 636674 2012 01 19

Lemon Chiffon Ventures Limited Saint John 638369 2012 01 19

Cogwheel Properties Limited Saint John 643063 2012 01 25

Charlie’s Trucking Inc. Saint-Charles 644139 2012 01 27

Braeside Solar Park 2 GP Inc. Saint John 653731 2012 01 23

MSD E-Commerce Solutions Ltd. Belleville 655032 2012 01 19

Cusack Real Property Consulting Ltd. Saint John 655248 2012 01 18

Canatara Solar 1 GP Inc. Saint John 657785 2012 01 23

_____________________________________________________

Deer Island Salmon Ltd. Lords Cove Ernst & Young Inc. 053503 2012 02 02

_____________________________________________________

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc./Groupe Tabac Scandinave Canada Inc.

Québec / Quebec 661314 2012 01 16

_____________________________________________________

O’BRIEN & LANDRY LIMITED 012504 2012 01 26

J.M. & C.W. HOPE GRANT LTD. 038664 2012 01 26

DUNCAN HOLDINGS LTD. 057091 2012 01 26

T & L Electrical Ltd. 615744 2012 01 26

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, notice of the discharge of a receiver or a receiver-manager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour lessociétés suivantes a été reçu :

Receiver or ReferenceReceiver-Manager Number Date

Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 302 Gazette royale — 22 février 2012

WENDY SERGEANT GENERAL CLEANING LTD. 620737 2012 01 27

Wards Creek Holdings Ltd. 634847 2012 01 26

_____________________________________________________

VANGUARD INVESTMENTS CANADA INC. PLACEMENTS VANGUARD CANADA INC.

Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

661605 2012 01 17

Specialty Risk Underwriters Inc. Canada David Bruce CannonIrishtown

661616 2012 01 17

Product Remanufacturing Centers Canada, Limited Centres de Remise à Neuf de Produits Canada, Limitée

Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

661626 2012 01 18

P.S. Atlantic Limited Terre-Neuve et Labrador/ Newfoundland and Labrador

Struan SmithMoncton

661666 2012 01 19

XEROX FINANCIAL SERVICES CANADA LTD./SERVICES FINANCIERS XEROX CANADA LTEE.

Ontario William T. WalkerFredericton

661705 2012 01 20

Affordable Plumbing & Mechanical Inc. Ontario Alison J. HarveyHaut-Sheila

661750 2012 01 24

ASPHALTE BAS-ST-LAURENT INC. Canada Daniel BélangerGrand-Sault / Grand Falls

661751 2012 01 24

Bouclair Inc. Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

661776 2012 01 25

Wingenback Inc. Alberta Sheryl D. TaborSussex

661777 2012 01 25

Bruns-Pak Worldwide, Inc. New Jersey Steven D. ChristieFredericton

661792 2012 01 25

FRONTLINE RAILCAR REPAIR LTD. Saskatchewan John B. MaloneSussex

661853 2012 01 27

Provident Agency, Inc. Canada Craig A. SampsonMoncton

661854 2012 01 27

ASSURANCES NORMAN MCCANN INC.

Québec / Quebec Norman McCannCaraquet

661873 2012 01 30

Tundra Consulting Inc. Nunavut R. Gary FaloonSaint John

661885 2012 01 30

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 303 Gazette royale — 22 février 2012

AZGA Insurance Agency Canada Ltd. WORLD ACCESS INSURANCE BROKERS LTD.

600874 2012 01 27

326551 Canada Inc. Bodkin Leasing Corporation 612286 2012 01 18

3267911 Canada Inc. Bodkin Capital Corporation 612287 2012 01 18

IKON Office Solutions ULC IKON OFFICE SOLUTIONS, INC./IKON SOLUTIONS DE BUREAU, INC.

615949 2012 01 23

AZGA Service Canada Inc. World Access Canada Inc. 639363 2012 01 27

Dynamitage Castonguay ltée /Castonguay Blasting Ltd.

DNX Castonguay Inc. 648699 2012 01 23

Atos IT Solutions and Services Inc./Atos Solutions et services en TI inc.

Siemens IT Solutions and Services Inc./Siemens Solutions et services en TI Inc.

651618 2012 01 31

Skyline Wealth Management Inc. Skyline Asset Management Inc. 653234 2012 01 24

FGL Sports Ltd. FGL Sports Ltee FGL AcquisitionCo Limited 661807 2012 01 26

_____________________________________________________

EXTENDICARE (CANADA) INC. EXTENDICARE (CANADA) INC. Steven ChristieFredericton

661088 2012 01 19

Siemens Canada Limited/Siemens Canada Limited

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC LTD.SIEMENS DIAGNOSTICS EN SOINS DE SANTÉ LTÉESIEMENS CANADA LIMITED /SIEMENS CANADA LTÉE

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661684 2012 01 20

NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

NEBS PAYROLL SERVICE LIMITEDNEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661685 2012 01 20

KODAK CANADA INC. KODAK CANADA INC. George L. CooperMoncton

661701 2012 01 20

Cliffs Chromite Ontario Inc. Cliffs Chromite Ontario Inc. George L. CooperMoncton

661702 2012 01 20

MGA PARTNERS INC. Blonde & Little Financial Services Ltd Terry FitzgeraldFredericton

661712 2012 01 20

Ricoh Canada Inc. IKON Office Solutions ULCRicoh Canada Inc.

Bernard F. MillerMoncton

661741 2012 01 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 304 Gazette royale — 22 février 2012

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Human Resource Capital Group Inc.Groupe Capital de Ressource Humaine Inc.Randstad Intérim Inc./Randstad Interim Inc.

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661744 2012 01 24

JIM PEPLINSKI LEASING INC. JIM PEPLINSKI’S AUTO LEASING LTD.HUMBERVIEW MOTORS INCORPORATED

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661771 2012 01 25

Homewood Human Solutions Canada Inc.

Homewood Human Solutions Canada Inc.

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661775 2012 01 25

The Forzani Group Ltd. SPORTS EXPERTS 2000 INC.THE FORZANI GROUP LTD.Sport-Chek International 2000 Ltd.

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661806 2012 01 26

FGL AcquisitionCo Limited The Forzani Group Ltd. Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661807 2012 01 26

LAFARGE CANADA INC. LAFARGE CANADA INC. Alex KennedyMoncton

661856 2012 01 27

Element Financial Corporation ELEMENT FINANCIAL CORPORATION

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661861 2012 01 27

Hazmasters Inc. Hazmasters Inc. Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661862 2012 01 27

LES BRAYONS MASQUÉS INC. Edmundston 661784 2012 01 25

HAITI VILLAGE HEALTH INC. Miramichi 661847 2012 01 27

CHILD CARE OWNERS’ & OPERATORS OF SOUTHERN NEW BRUNSWICK INC.

Saint John 661906 2012 01 31

_____________________________________________________

MULTICULTURAL ASSOCIATION OF FREDERICTON INC. 011467 2012 01 27

_____________________________________________________

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 305 Gazette royale — 22 février 2012

MEMRAMCOOK VOLUNTEER FIREMEN’S ASSOC. INC. - L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE MEMRAMCOOK INC.

010863 2012 01 27

NORTH SHORE CINEMA 633970 N.B. Limited Campbellton 661172 2012 01 26

Tradewinds Truck Service Scoudouc Truck Service Inc. Shediac 661492 2012 01 23

Bay of Fundy Adventures 630227 N.B. INC. Rothesay 661613 2012 01 17

Kane Construction 630227 N.B. INC. Rothesay 661614 2012 01 17

GOLD BUYERS NEW BRUNSWICK Mark Rzepka Saint John 661625 2012 01 18

Fairvale Physiotherapy Clinic PT Health NB Professional Corporation

Rothesay 661639 2012 01 18

River Valley Ventilation & Heating Luke Dukeshire Northampton 661662 2012 01 27

Stever-Ryu Jujutsu Nathan Stever Big River 661664 2012 01 19

SWIT SWOO SERVICES Harvey A. Hillis Florenceville-Bristol 661669 2012 02 01

Agence basKASTing Agency Julie Basque Tracadie-Sheila 661671 2012 01 31

Buanderie Dieppe Laundry 659298 NB INC. Dieppe 661697 2012 01 20

TARGET TARGET CANADA CO. Saint John 661717 2012 01 23

TARGET CANADA TARGET CANADA CO. Saint John 661718 2012 01 23

MAISONS LEVESQUE GÉRANCE DE PROJET RÉSIDENTIEL

Dieppe 661724 2012 01 23

KANE HOMES 630227 N.B. INC. Rothesay 661729 2012 01 23

Salon Milady Denise Lanteigne Caraquet 661730 2012 01 23

The General Store St. Andrews 659761 N.B. INC. Saint Andrews 661734 2012 01 27

Kevin Dinsmore Painting Kevin Dinsmore Pomeroy Ridge 661739 2012 01 23

VETEMENTS O BON PRIX ENR. CHEZ ROBICHAUD LTEE Shippagan 661752 2012 01 24

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 306 Gazette royale — 22 février 2012

KV VINEYARD KENNEBECASIS VALLEY VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP INC.

Quispamsis 661763 2012 01 24

TEAM BESLER MGI SECURITIES INC. Saint John 661778 2012 01 25

Moncton Kiwanis Basketball Association

MONCTON MINOR BASKETBALL ASSOCIATION, Inc.

Moncton 661780 2012 01 25

New Brunswick Northern Railway Company

NEW BRUNSWICK SOUTHERNRAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAU-BRUNSWICK LIMITEE

Saint John 661785 2012 01 25

NB Northern NEW BRUNSWICK SOUTHERNRAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAU-BRUNSWICK LIMITEE

Saint John 661787 2012 01 25

Raduga Market Gelena Devedjinejad Moncton 661788 2012 01 25

Modern Hüs Jon-Matthew O’Hara Moncton 661815 2012 01 26

KING PERFORMANCE Gordon King Fredericton 661816 2012 01 26

DUKE CREATIVE COLLECTIVE Elizabeth Richardson Saint John 661825 2012 01 26

SAILBLOG.NET Michael Taylor Saint John 661834 2012 01 27

Centre de conditionnement ÉducACTION (Edmundston)

Mike Couturier Edmundston 661837 2012 01 27

FACE-IT GENEVIÈVE Geneviève Albert Moncton 661838 2012 01 27

Hubert Williston Renovations and Construction

Hubert Williston Napan 661844 2012 01 27

MCGUIRE REHAB RENOS MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.

Saint John 661848 2012 01 27

MCGUIRE’S TRINKETS & TREASURES

MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.

Saint John 661849 2012 01 27

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE AZGA Insurance Agency Canada Ltd.

Saint John 661857 2012 01 27

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE AZGA Service Canada Inc. Saint John 661858 2012 01 27

SNACKMAN VENDING SERVICES Chris Morrison Moncton 661865 2012 01 27

Sussex Ventilation & Heating Gordon Keddy Sussex 661875 2012 01 30

Yellowline Vending Tim Rose Moncton 661878 2012 01 30

VÂN’s NAILS BichVan Tuthi Bathurst 661879 2012 01 30

Progress at Home Physiotherapy Natalie Ann Brand Russell Quispamsis 661888 2012 01 30

RRNJ Style Sales Roxanne Maillet Moncton 661890 2012 01 30

Chris Parks Trucking Chris Parks Moncton 661895 2012 01 31

JOE’S WOODWORKING Joe Pitre Fredericton 661900 2012 01 31

Sunset Realty Group David Boucher Dieppe 661901 2012 01 31

R. Nason Renovations Rick Nason Geary 661904 2012 01 31

ADRIAN FORGIE BUILDER CONTRACTOR

Adrian Forgie Rothesay 661910 2012 01 31

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 307 Gazette royale — 22 février 2012

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on January 18, 2012 under the Act, under the name of “Fundy Flair For Hair”, being file#661648, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the name of the person in section 3 of form 5 be corrected toread as follows “Tammie Wyttner”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 18 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « Fundy FlairFor Hair », dont le numéro d’appellation commerciale est 661648, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que le nom de lapersonne indiquée à la section 3 du formulaire 5 soit corrigé pour qu’il se lise comme suit : « Tammie Wyttner ».

_____________________________________________________

In relation to the certificate of business name registered on January 31, 2012 under the Act, under the name of “JPS SIGNS AND IDENTIFICA-TIONS SOLUTIONS”, being file #661911, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name becorrected to read as follows: “JPS SIGNS AND IDENTIFICATION SOLUTIONS”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 31 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « JPS SIGNSAND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS », dont le numéro d’appellation commerciale est 661911, le registraire a ordonné, conformément à l’ar-ticle 17 de la Loi, que l’appellation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONSOLUTIONS ».

_____________________________________________________

JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS

Dwight Cummings Saint John 661911 2012 01 31

MR HANDYMAN BY SERGE Serge Ethier Saint John 661912 2012 01 31

LAURA COMEAU ART Laura Lea Wergin Comeau Derby 661917 2012 01 31

Barachois Vehicle Import Personal Auto Sales

John MacNeill Grand-Barachois 661919 2012 01 31

S. Macphee Auto Salvage Scott Macphee Petitcodiac 661920 2012 01 31

FK MotoTech Francis Séguin Oromocto 661922 2012 01 31

NINE-DOT MARKETING Christopher Bastarache Moncton 661925 2012 02 01

Sweetstix Treats Adrianna Stevens Moncton 661926 2012 02 01

NLB Nuclear Process Services Normand L. Boucher, P.Eng Saint John 661935 2012 02 01

Phil’s Automation Industrial Control Systems

Philip Kilpatrick Picadilly 661938 2012 02 01

BDLAW Brent A. Dickinson Woodstock 661940 2012 02 01

Exclusive Events Jennifer Mae Rose Oromocto 661943 2012 02 01

Natures Pet Spa Jennifer Stenzler Dieppe 661966 2012 02 02

VERNON BISHOP TOWING Vernon Bishop Chipman 321834 2012 01 26

LITECO Liteco Inc. Fredericton 323853 2012 02 01

LA ROMA MOTEL ENRG. 058429 N.B. INC. Saint-Basile 335005 2012 01 26

CNC GLOBAL SEARCH Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 346054 2012 01 24

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 308 Gazette royale — 22 février 2012

CNC GLOBAL CONSULTING Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 346055 2012 01 24

B.A.S.A. RÉPARATIONS & SERVICES

Frederic Savoie Balmoral 350623 2012 01 30

McKINNON EXCAV. Mark A. McKinnon Quispamsis 350784 2012 01 26

LITETEC Liteco Inc. Fredericton 351058 2012 02 01

CCS - Complete Computer Service Frank David MacNeil New Maryland 353277 2012 01 31

WESTFIELD BEACH ENTERPRISES

Avril Wood-Toner Grand Bay-Westfield 353304 2012 01 27

The DFS Group NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Saint John 603935 2012 01 20

POWER DAWG Liteco Inc. Fredericton 605858 2012 02 01

SPHERION Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 615659 2012 01 24

Altron Color Imaging Kevin Frenette Moncton 628922 2012 01 28

CLINIQUE TENDANCE SANTÉ NATHALIE

Nathalie Noel-DoironHazel McMullin

Shippagan 629048 2012 01 26

Le Bon Sang Denise Gallant Bouctouche 629225 2012 01 28

Countertop Creations COUNTERTOPS PLUS LTD. Moncton 629261 2012 01 24

Blaney Cycle Supply Barry Blaney Nortondale 629387 2012 01 26

John Maunder Insurance Capital Insurance Services Ltd. Fredericton 630849 2012 01 25

DFS Business Forms NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Saint John 635532 2012 01 20

TODAYS STAFFING Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 636207 2012 01 24

Sapphire Global Services Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 643769 2012 01 24

Silver Group Purchasing EXTENDICARE (CANADA) INC.

Fredericton 650621 2012 01 19

CANADA’S CAR MART OLeary Buick GMC (Saint John Ltd.)

Saint John 651033 2012 01 24

Randstad Technologies Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John 658060 2012 01 24

_____________________________________________________

FAIRVALE PHYSIOTHERAPY CLINIC Rothesay 335391 2012 01 18

JIM PEPLINSKI’S LEASEMASTER NATIONAL Saint John 349576 2012 01 25

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 309 Gazette royale — 22 février 2012

Jean Léger & Son Contracting McKees Mills 607999 2012 01 27

LAID BACK PUB Grand-Sault / Grand Falls 608391 2012 02 01

Wendy Sergeant General Cleaning Bathurst 610451 2012 01 27

FREDDIE’S PIZZA Moncton 618158 2012 01 31

DOMAINE DU RUISSEAU Dieppe 636511 2012 01 31

Mondial Assistance Saint John 638804 2012 01 27

Mondial Assistance Saint John 639364 2012 01 27

MSP Work Solutions / Solutions au travail MSP Dieppe 654282 2012 01 30

Tradewinds Truck Service Shediac 658443 2012 01 23

Pet Grooming by Jennifer Dieppe 658890 2012 02 02

Xylem Residential & Commercial Water Saint John 661457 2012 01 31

Xylem Water Solutions Saint John 661458 2012 01 31

_____________________________________________________

ROBERT BURY & COMPANY (CANADA) Don PoleyMoncton

628641 2012 01 24

_____________________________________________________

HIGHLITE HAIR SALON Kevin RussellWilliam Russell

Miramichi 661540 2012 01 27

Hilton Spring Farm Ruby SpencerBrian Spencer

Parker Ridge 661617 2012 01 17

Frufrus “Asian skin care and beauty products”

Jerome Janson OngDjoana Marie Wasson

Fredericton 661672 2012 01 19

Rowan McGrath Lawyers Donald Rowan Law Professional CorporationElizabeth Mary McGrath

Fredericton 661686 2012 01 20

HARBOUR CENTRE John LawsonDon Sterritt

Saint John 661727 2012 01 23

KALIE’S BUTTERFLIES Marie Ann HarrisonJena Lynn Beauchamp

Gagetown 661764 2012 01 24

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of agent forservice has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

ReferenceNumber Date

Agent and Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 310 Gazette royale — 22 février 2012

Soucy Richard Soucy Richard Godbout Wallace Dieppe 625392 2012 02 01

_____________________________________________________

Soucy Richard Pierre S. SoucyMarc-André Richard

Dieppe 625392 2012 02 01

Resto Ma-Gi-Co Gisele BoudreauMarie-May Boudreau

Shediac 629047 2012 01 24

_____________________________________________________

Spacek & Associates Chartered Accountants

Bruce Lunergan Professional Corporation

Nick Norrad Professional Corporation

345806 2011 12 28

Shell Canada Upstream Duvernay Oil Corp. Shell Canada Limited 641663 2012 01 25

Matrix 2012 - I National and Quebec Resource Flow Through LP

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661627 2012 01 18

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of firmname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement de raison sociale a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Date

Previous Name commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 311 Gazette royale — 22 février 2012

HETTICH CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Moncton Ontario Bob VautourMoncton

661670 2012 01 19

Sprott 2012 Flow-Through Limited Partnership

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661716 2012 01 23

QWEST 2012 OIL & GAS FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP

Saint John Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

661743 2012 01 24

NOTICE UNDER THECOMMUNITY PLANNING ACT

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under the Com-munity Planning Act, subsection 77(2.96), Ministerial Regula-tion for the Chamcook Planning Area under the CommunityPlanning Act, being Ministerial Regulation 11-CHA-036-00,otherwise cited as the Chamcook Planning Area Rural PlanRegulation - Community Planning Act, was enacted by the Min-ister of Environment on January 16, 2012 and filed in theCharlotte County Registry office on January 24, 2012 under of-ficial number 31089155.

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, chapter C-32.2, that theCaisse populaire Sud-Est Ltée has amended its articles effectiveDecember 23, 2011.

Pierre LeBlanc, CASuperintendent of Credit Unions

________________

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, Chapter C-32.2, that LaCaisse Populaire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaireKent-Centre Ltée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caissepopulaire Kent-Sud Ltée, and Caisse populaire Sud-Est Ltéehave amalgamated effective the 1st day of January, 2012 underthe name Caisse populaire Sud-Est Ltée and that the provisionsof the Credit Unions Act have been complied with.

Pierre LeBlanc, CASuperintendent of Credit Unions

Department of Environment

Department of Justiceand Consumer Affairs

AVIS CONFORMÉMENT À LALOI SUR L’URBANISME

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LES PRÉSENTES, confor-mément au paragraphe 77(2.96) de la Loi sur l’urbanisme,qu’un règlement ministériel pour du secteur d’aménagement deChamcook, établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, soit le Rè-glement ministériel 11-CHA-036-00, autrement cité comme leRèglement établissant le plan rural du secteur d’aménagementde Chamcook - Loi sur l’urbanisme, a été adopté par la ministrede l’Environnement le 16 janvier 2012 et a été déposé au bureaud’enregistrement du comté de Charlotte le 24 janvier 2012 sousle numéro 31089155.

Sachez, en vertu du sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur lescaisses populaires, chapitre C-32.2, que la Caisse populaireSud-Est Ltée a modifié ses statuts en date du 23 décembre 2011.

Le surintendant des caisses populairesPierre LeBlanc, c.a.

________________

Sachez que, conformément au sous-alinéa 285(2)b)(iv) de laLoi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2, La Caisse Popu-laire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaire Kent-CentreLtée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caisse populaire Kent-Sud Ltée, et Caisse populaire Sud-Est Ltée ont fusionné pourdevenir à compter du 1 janvier 2012 Caisse populaire Sud-EstLtée et que toutes les dispositions de la Loi sur les caisses po-pulaires ont été respectées.

Le surintendant des caisses populairesPierre LeBlanc, c.a.

Ministère del’Environnement

Ministère de la Justiceet de la Consommation

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 312 Gazette royale — 22 février 2012

DEMANDE DE COMMENTAIRESAvis de consultation et demande de commentaires – Publica-tion en vue de recueillir des commentaires sur :

• le projet de la Norme multilatérale 32-102 sur les dis-penses d’inscription des gestionnaires de fonds d’inves-tissement non-résidents (NM 32-102);

• le projet de l’Instruction complémentaire 32-102IC(32-102IC); et

• les modifications corrélatives proposées à l’Instructioncomplémentaire 31-103IC relative à la Norme cana-dienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscrip-tion et les obligations continues des personnes inscrites(31-103IC)

(collectivement, les textes proposés).

IntroductionLe 23 janvier 2012, la Commission des valeurs mobilières duNouveau-Brunswick (Commission) a autorisé la publication envue de recueillir des commentaires sur les textes proposés.

Résumé des textes proposésNM 32-102 et 32-102IC s’appliqueraient en Ontario, auQuébec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador(les territoires) et établiraient des dispenses d’inscription pourles gestionnaires de fonds d’investissement qui n’ont pas leursiège ou leur établissement principal situé dans un territoire duCanada et qui n’ont pas d’établissement dans le territoire inté-ressé (les gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents).La règle proposée dispenserait les gestionnaires de fonds d’in-vestissement non-résidents de l’obligation de s’inscrire dans lesterritoires lorsqu’il n’y a pas de facteur de rattachement signifi-catif avec le territoire intéressé.NM 32-102 prévoit une dispense de l’obligation d’inscription àtitre de gestionnaire de fonds d’investissement dans le cas où iln’y a aucun porteur du fonds d’investissement ou démarchageactif de résidents dans le territoire intéressé. 32-102IC fournitdes indications sur ce qui serait considéré ou non comme du dé-marchage actif. La règle proposée prévoit également une dis-pense dans le cas où le placement des titres du fonds au Canadase serait limité à des clients autorisésLe but de la modification corrélative de l’article 7.3 de31-103IC est de renvoyer les lecteurs aux indications concer-nant l’obligation d’inscription des gestionnaires de fonds d’in-vestissement non-résidents.

Demande de commentairesLa Commission désire prendre connaissance de vos commen-taires au sujet des textes proposés mais uniquement dans la me-sure où cela s’applique au Nouveau-Brunswick.

Commission des valeursmobilières du Nouveau-Brunswick

REQUEST FOR COMMENTSNotice and Request for Comment – Publishing for comments:

• proposed Multilateral Instrument 32-102 RegistrationExemptions for Non-Resident Investment Fund Managers(MI 32-102);

• proposed Companion Policy 32-102CP (32-102CP); and

• proposed consequential amendments to Companion Pol-icy 31-103CP Registration Requirements, Exemptionsand Ongoing Registrant Obligations (31-103CP)

(together, the Proposed Materials).

IntroductionOn January 23rd, 2012, the New Brunswick Securities Commis-sion (Commission) approved publication in order to obtaincomments on the Proposed Materials.

Summary of Proposed MaterialsMI 32-102 and 32-102CP would apply in Ontario, Québec,New Brunswick and Newfoundland and Labrador (the jurisdic-tions) and relate to proposed registration exemptions for invest-ment fund managers that do not have their head office or theirprincipal place of business in a jurisdiction of Canada and thatdo not have a place of business in the local jurisdiction (non-resident investment fund managers).

MI 32-102 would exempt non-resident investment fund manag-ers from the requirement to register in the jurisdictions in cir-cumstances where there are no significant connecting factors tothe local jurisdiction.The Proposed Materials include an exemption from the invest-ment fund manager registration in circumstances where thereare no security holders of the investment fund, or active solici-tation of residents, in the local jurisdiction. 32-102CP providesguidance on what would and would not be considered active so-licitation. The proposed rule also provides an exemption in cir-cumstances where the Canadian distribution of the fund’s secu-rities would be restricted to permitted clients.The purpose of the proposed consequential amendment to sec-tion 7.3 of 31-103CP is to provide references to applicable guid-ance on the registration requirement for non-resident invest-ment fund managers.

Request for CommentThe Commission welcomes your comments on the ProposedMaterials as they apply to New Brunswick only.

New BrunswickSecurities Commission

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 313 Gazette royale — 22 février 2012

How to Obtain a Copy and Provide your Comments

The text of the Proposed Materials as well as a more detailednotice can be obtained from the Commission website at:www.nbsc-cvmnb.ca.

A paper copy of the Proposed Materials may be obtained bywriting, telephoning or e-mailing the Commission. Commentsare to be provided, in writing, by no later than April 10th, 2012,to:

SecretaryNew Brunswick Securities Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 1-866-933-2222 (within N.B. only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

We cannot keep submissions confidential because securitieslegislation in certain provinces requires that a summary of thewritten comments received during the comment period bepublished.

QuestionsIf you have any questions, please refer them to:

Kevin HoytDirector, Regulatory AffairsNew Brunswick Securities CommissionTel: 506-643-7691Email: [email protected]

TO: FLOYD JOSEPH GALLANT AND MARIE NORMAGALLANT, Mortgagors;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 10 Hamilton Beach Road, Charlo, Prov-ince of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number50068675.Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINIONBANK.The sale is scheduled for Thursday, March 22, 2012, at 11:00a.m., at the Campbellton Court House, 157 Water Street,Campbellton, New Brunswick.

Notices of Sale

Pour prendre connaissance des documents et nous faire part de vos commentairesOn trouvera les documents énoncés ci-dessus ainsi qu’un avisplus détaillé par l’entremise du site web de la Commission :www.nbsc-cvmnb.ca.

On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autrede ces documents en communiquant par courrier, par téléphoneou par courriel avec la Commission. Veuillez nous faire part devos commentaires par écrit au plus tard le 10 avril 2012 àl’adresse suivante :

SecrétaireCommission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

Nous sommes incapables de garantir la confidentialité des com-mentaires formulés, étant donné que les mesures législatives surles valeurs mobilières de certaines provinces exigent que soitpublié un résumé des observations écrites qui sont reçues aucours de la période de consultation.

QuestionsSi vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avecla personne suivante :

Kevin HoytDirecteur des affaires réglementaires Commission des valeurs mobilières du Nouveau-BrunswickTéléphone : 506-643-7691Courriel : [email protected]

DESTINATAIRES : FLOYD JOSEPH GALLANT ETMARIE NORMA GALLANT, débiteurs hypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B.1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 10, cheminHamilton Beach, Charlo, province du Nouveau-Brunswick, etayant le numéro d’identification parcellaire 50068675.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 22 mars 2012, à 11 h, au palais dejustice de Campbellton, 157, rue Water, Campbellton(Nouveau-Brunswick).

Avis de vente

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 314 Gazette royale — 22 février 2012

See advertisements in The Tribune in the issues of February 24,March 2, March 9 and March 16, 2012.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for TheToronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)

________________

TO: RÉJEAN GEORGE COMEAU AND SOPHIE ROY,Mortgagors;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 203 Marie Street, Beresford, in theCounty of Gloucester, Province of New Brunswick and knownas Parcel Identifier Number 20774998.

Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINIONBANK.The sale is scheduled for Wednesday, March 21, 2012, at11:00 a.m., at the Bathurst Court House, 254 St. Patrick Street,Bathurst, New Brunswick. See advertisements in The Northern Light, in the issues of Feb-ruary 21, February 28, March 6 and March 13, 2012.DATED this 25th day of January, 2012.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: ROBERT M. CREAMER, Solicitors forTHE TORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Darren Robert Hanselpacker and Julie Marie Hanselpacker,original Mortgagors; and to all others whom it may concern.Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property ActR.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Free-hold property being situated at 96 Brunswick Street, St. George,New Brunswick, the same lot conveyed to Darren RobertHanselpacker and Julie Marie Hanselpacker by Deed registeredin the Charlotte County Registry Office on October 22nd, 1999,in Book 703, Pages 355-358, as document number 10572619.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the Offices of Service New Brunswick locatedat 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick on the7th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. Seeadvertisement of Notice of Sale in the Telegraph-Journal datedFebruary 7, February 14, February 21 and February 28, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Voir l’annonce publiée dans les éditions du 24 février et des2, 9 et 16 mars 2012 du Tribune.

Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER,avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD CanadaTrust)

________________

DESTINATAIRES : RÉJEAN GEORGE COMEAU ETSOPHIE ROY, débiteurs hypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 203, rue Marie,Beresford, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est20774998.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le mercredi 21 mars 2012, à 11 h, au palaisde justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 21 et 28 février etdes 6 et 13 mars 2012 du Northern Light.FAIT le 25 janvier 2012.

ROBERT M. CREAMER, du cabinet LAWSON &CREAMER, avocats de LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD Canada Trust)

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Darren Robert Hanselpacker et Julie MarieHanselpacker, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autreintéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions del’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 96, rueBrunswick, St. George (Nouveau-Brunswick), et correspondantau même lot ayant été transféré à Darren Robert Hanselpackeret Julie Marie Hanselpacker par l’acte de transfert enregistré aubureau de l’enregistrement du comté de Charlotte le 22 octobre1999, sous le numéro 10572619, aux pages 355 à 358 du regis-tre 703.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 7 mars 2012, à 11 h,heure locale, au centre de Services Nouveau-Brunswick, situéau 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 fé-vrier 2012 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 315 Gazette royale — 22 février 2012

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Jennifer Audrey Stacey, original Mortgagor; and to all oth-ers whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mort-gage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts inamendment thereof. Freehold property being situated at33 Killarney Road, Riverview, New Brunswick, the same lotconveyed to Jennifer Audrey Stacey by Transfer registered inthe Land Titles Office on June 27, 2006, as document number22329297.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held atMoncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick, on the 2nd day of March, 2012, at the hour of 11:00a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in theTimes & Transcript dated February 2, February 9, February 16and February 23, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: MathieuR. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Preston Fraser Hooper, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 336 Route785, Utopia, New Brunswick, the same lot conveyed to PrestonFraser Hooper by Transfer registered in the Land Titles Officeon September 29, 2003, as document number 17142481.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at theOffices of Service New Brunswick located 73 Milltown Boule-vard, St. Stephen, New Brunswick, on the 7th day of March,2012, at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Times & Transcript dated February 2, Feb-ruary 9, February 16 and February 23, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: MathieuR. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs, original Mortgagors;and to all others whom it may concern. Sale pursuant to termsof the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19and Acts in amendment thereof. Freehold property being situ-ated at 304 Debec Road, Debec, New Brunswick, the same lotconveyed to Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs by Transferregistered in the Land Titles Office on August 27, 1999, as doc-ument number 10444645.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Jennifer Audrey Stacey, débitrice hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libresitués au 33, chemin Killarney, Riverview (Nouveau-Brunswick), correspondant au même lot ayant été transféré àJennifer Audrey Stacey par l’acte de transfert enregistré au bu-reau de l’enregistrement foncier le 27 juin 2006 sous le numéro22329297. Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 2 mars 2012, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville deMoncton, situé au 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times & Transcript.

Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataire : Preston Fraser Hooper, débiteur hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libresitués au 336, route 785, Utopia (Nouveau-Brunswick), et cor-respondant au même lot ayant été transféré à Preston FraserHooper par l’acte de transfert enregistré au bureau d’enregistre-ment foncier le 29 septembre 2003, sous le numéro 17142481.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 7 mars 2012, à 11 h 15, heure locale, au centre deServices Nouveau-Brunswick, situé au 73, boulevard Milltown,St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiéedans les éditions des 2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times &Transcript.

Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs, débiteurshypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19. Biens en tenure libre situés au 304, chemin de Debec,Debec (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lotayant été transféré à Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs parl’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement fon-cier le 27 août 1999, sous le numéro 10444645.

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 316 Gazette royale — 22 février 2012

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort-gagee. Sale to be held at the Woodstock Court House located at689 Main Street, Woodstock, New Brunswick on the 6th day ofMarch, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Sale in the Bugle-Observer dated Febru-ary 7, February 14, February 21 and February 28, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 QueenStreet, P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick,E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

________________

TO: BRUCE D. HEPPERLE/BRUCE DARWINHEPPERLE and CAROLE J. HEPPERLE/JEANNINECAROLE HEPPERLE, of 450 Route 628, Penniac, in theCounty of York and Province of New Brunswick, Mortgagor;

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 504 Queen Street,Fredericton, New Brunswick, E3G 5G1, Holder of the FirstMortgage;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at 450 Route 628,Penniac, County of York and Province of New Brunswick.Notice of Sale given by Secure Capital MIC Inc., holder of asecond mortgage.Sale on the 20th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m.,at the Fredericton Court House located at 427 Queen Street,Fredericton, New Brunswick. See advertisement in The DailyGleaner.

MacLean Law, Solicitors for the Mortgagee, Secure CapitalMIC Inc.

________________

TO: JESSIE JAMES SAUNDERS, Mortgagor;

AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 11 Leo Road, Shediac River, Westmor-land County, Province of New Brunswick and known as ParcelIdentifier Number 70095021.

Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The sale is scheduled for Friday, March 23, 2012, at 11:00 a.m.,at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick.See advertisements in the Times & Transcript in the issues ofFebruary 22, February 29, March 7 and March 14, 2012.

TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for TheToronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)

________________

Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h,heure locale, au palais de justice de Woodstock situé au 689, rueMain, Woodstock (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce pu-bliée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 février 2012 du Bugle-Observer.

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laSociété hypothécaire Scotia, Barker House, bureau 600,570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :506-458-9903

________________

DESTINATAIRES : BRUCE D. HEPPERLE/BRUCEDARWIN HEPPERLE et CAROLE J. HEPPERLE/JEANNINE CAROLE HEPPERLE, du 450, route 628,Penniac, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, dé-biteurs hypothécaires;LA BANQUE ROYALE DU CANADA, 504, rue Queen,Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G1, titulaire de lapremière hypothèque;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 450, route 628, Penniac, comtéde York, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par Secure Capital MIC Inc., titulaire de ladeuxième hypothèque.La vente aura lieu le 20 mars 2012, à 11 h, au palais de justicede Fredericton situé au 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner.

MacLean Law, avocats du créancier hypothécaire, Secure Capi-tal MIC Inc.

________________

DESTINATAIRE : JESSIE JAMES SAUNDERS, débiteurhypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 11, chemin Leo,Shediac River, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est70095021.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le vendredi 23 mars 2012, à 11 h, à l’hôtel deville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 22 et 29 février etdes 7 et 14 mars 2012 du Times & Transcript.

Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER,avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD CanadaTrust)

________________

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 317 Gazette royale — 22 février 2012

To: ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANC ESCALI-ERS CERAMIQUE LTÉE, 4024 des Fondateurs Boulevard,in Saint-Isidore, Gloucester County and Province of NewBrunswick, Mortgagor;CBDC Peninsule Acadienne Inc., subsequent Mortgagee;

AND TO ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at 4024 des Fonda-teurs Boulevard, in Saint-Isidore, Gloucester County and Prov-ince of New Brunswick.NOTICE OF SALE given by Caisse Populaire Le Lien d’OrLtee, now known as Caisse populaire le Lien des deuxRivières Ltée following an amalgamation on January 1st, 2012,as Mortgagee and Holder of the First Mortgage by virtue of thepower of sale contained in the mortgage and the Property Act.

Sale to be held on the 6th day of March, 2012, at 11:00 a.m., atthe Saint-Isidore Municipal Building, located at 3906 des Fon-dateurs Boulevard, in Saint-Isidore, in the County of Glouces-ter, New Brunswick.SEE ADVERTISEMENT IN L’ACADIE NOUVELLE.

JONATHAN ROCH NOËL, Solicitor for Caisse Populaire leLien des deux Rivières Ltée

________________

To: Romain Georges Murray, of the City of Bathurst, in theCounty of Gloucester and Province of New Brunswick, andMarie Monique Murray, of the City of Bathurst, in the Countyof Gloucester and Province of New Brunswick, Mortgagors;

And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 1690 SunsetDrive, in the City of Bathurst, in the County of Gloucester andProvince of New Brunswick, PID 20614665.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 22nd day of March, 2012, at the hour of11:00 o’clock in the forenoon, at the Court House in Bathurst,254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. The Mort-gagee reserves the right to postpone or reschedule the time anddate of sale. See advertisement in The Northern Light.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

TO: DUANE ALEXANDER GEIKIE, of 140 Pond Street,Miramichi, in the County of Northumberland and Province ofNew Brunswick, Mortgagor;AND TO: EVA GEIKIE, of 140 Pond Street, Miramichi, in theCounty of Northumberland and Province of New Brunswick,Spouse of Duane Alexander Geikie;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 40164014, situate, lying andbeing at 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northum-berland and Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.

Destinataire : ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANCESCALIERS CERAMIQUE LTÉE, 4024, boulevard desFondateurs, à Saint-Isidore, comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire;CBDC Péninsule Acadienne Inc., créancière hypothécairesubséquente;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Bien en tenure libre situé au 4024, boul. des Fondateurs, àSaint-Isidore, dans le comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick.AVIS DE VENTE donné par la Caisse Populaire Le Liend’Or Limitée, maintenant connu sous le nom de Caisse popu-laire le Lien des deux Rivières Ltée suite à une fusion en datedu 1er janvier 2012, titulaire de la première hypothèque en vertudu pouvoir de vente contenu dans l’acte d’hypothèque et de laLoi sur les biens.La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h à l’entrée de l’édificemunicipal du village de Saint-Isidore, situé au 3906, boulevarddes Fondateurs, à Saint-Isidore, dans le comté de Gloucester, auNouveau-Brunswick.VOIR L’ANNONCE DANS L’ACADIE NOUVELLE.

JONATHAN ROCH NOËL, avocat pour la Caisse Populaire leLien des deux Rivières Ltée

________________

Destinataires : Romain Georges Murray, de la ville de Bathurst,comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, etMarie Monique Murray, de la ville de Bathurst, comté deGloucester, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypo-thécaires;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 1690, promenade Sunset, ville deBathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 20614665.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 22 mars 2012, à 11 h, au palais de justicede Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans The Northern Light.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

DESTINATAIRES : DUANE ALEXANDER GEIKIE, du140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, provincedu Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire;EVA GEIKIE, du 140, rue Pond, Miramichi, comté deNorthumberland, province du Nouveau-Brunswick, conjointede Duane Alexander Geikie;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 140, rue Pond, Miramichi, comtéde Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dontle numéro d’identification est 40164014.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 318 Gazette royale — 22 février 2012

Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the CountyCourt House, 673 King George Highway, Miramichi, NewBrunswick.See advertisement in the Miramichi Leader.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.

DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.

WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank

________________

TO: MICHAEL IAN MACKINNON, of 1061 McLeod HillRoad, McLeod Hill, in the County of York and Province of NewBrunswick, Mortgagor;TO: CANADA REVENUE AGENCY, of 126 Prince WilliamStreet, Saint John, in the Province of New Brunswick;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 75156539, situate, lying andbeing at 1061 McLeod Hill Road, McLeod Hill, in the Countyof York and Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.Sale on the 19th day of March, 2012, at 11:00 a.m., at theFredericton Court House, 427 Queen Street, in the City ofFredericton, in the County of York, New Brunswick.See advertisement in The Daily Gleaner.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.

DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.

WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank

________________

To: Gary Stephen Siddall and Angela Marie Siddall, ofBelleville, in the County of Carleton and Province of NewBrunswick, Mortgagors;And to: Royal Bank of Canada, c/o Cox & Palmer, 644 MainStreet, Moncton, New Brunswick, E1C 1E2, Judgment Credi-tor;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 268 McLellanRoad, Belleville, in the County of Carleton and Province ofNew Brunswick, PID Number 10149342.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.

La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justicedu comté, 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans le Miramichi Leader.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, cha-pitre P-19.FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion

________________

DESTINATAIRES : MICHAEL IAN MACKINNON, du1061, chemin de McLeod Hill, McLeod Hill, comté de York,province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire;AGENCE DU REVENU DU CANADA, 126, rue PrinceWilliam, Saint John, province du Nouveau-Brunswick;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 1061, chemin de McLeod Hill,McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 75156539.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 19 mars 2012, à 11 h, au palais de justicede Fredericton, 427, rue Queen, ville de Fredericton, comté deYork, province du Nouveau-Brunswick.Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, cha-pitre P-19.FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion

________________

Destinataires : Gary Stephen Siddall et Angela Marie Siddall,de Belleville, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Banque Royale du Canada, a/s de Cox & Palmer, 644, rue Main,Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2, créancière sur juge-ment;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 268, chemin McLellan,Belleville, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 10149342.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 319 Gazette royale — 22 février 2012

Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the CourtHouse in Woodstock, 689 Main Street, Woodstock, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement inThe Bugle.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

TO: Charles James Donaher, of Targetville, in the County ofKent and Province of New Brunswick, Mortgagor;

AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at 2710 Route 510,Targetville, in the County of Kent and Province of NewBrunswick, also known as PID #25279803.Notice of Sale given by Advance Savings Credit Union Limited(formerly Rexton Credit Union Limited), holder of the firstmortgage.Sale on the 4th day of April, 2012, at 11:00 a.m., at theBouctouche Town Hall, 211 Irving Boulevard, Bouctouche,New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postponeor reschedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, Advance SavingsCredit Union Limited

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30

Notice to Advertisers

La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justicede Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans The Bugle.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

DESTINATAIRE : Charles James Donaher, de Targetville,comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hy-pothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 2710, route 510, Targetville,comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, et dont leNID est 25279803.Avis de vente donné par Advance Savings Credit Union Limi-ted (anciennement Rexton Credit Union Limited), titulaire de lapremière hypothèque.La vente aura lieu le 4 avril 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville deBouctouche, 211, boulevard Irving, Bouctouche (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.

Cox & Palmer, avocats du créancier hypothécaire, Advance Sa-vings Credit Union Limited

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $

Avis aux annonceurs

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22)Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations

The Royal Gazette — February 22, 2012 320 Gazette royale — 22 février 2012

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney general/royal gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]

Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur general/gazette royale.html

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899

Courriel : [email protected]

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lefinancement de l’activité politique

20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés