the royal gazette / gazette royale (15/05/27) · the royal gazette — may 27, 2015 635 gazette...

38
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 173 Wednesday, May 27, 2015 / Le mercredi 27 mai 2015 633 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. APRIL 30, 2015 2015-84 1. Under subsection 15(6) of the Electricity Act, the Lieutenant-Governor in Council acknowledges receipt of the skills and qualifications required of the board of directors as a whole in order for the board to carry out its functions, and the skills and qualification requirements for nominees for the board of directors position or positions to be filled. 2. Under paragraph 15(7)(c) of the Electricity Act, the Lieutenant-Governor in Council acknowledges receipt of a de- scription of the recruitment, assessment and selection processes used and the results of those processes. 3. Under paragraph 15(2)(b) and subsection 15(3) of the Elec- tricity Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints, from among those persons nominated by the board of directors of the New Brunswick Power Corporation, the following persons as Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. LE 30 AVRIL 2015 2015-84 1. En vertu du paragraphe 15(6) de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil accuse réception des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administra- tion dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonc- tions, ainsi que des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein. 2. En vertu de l’alinéa 15(7)c) de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil accuse réception d’une des- cription des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélec- tion utilisées et de leurs résultats. 3. En vertu de l’alinéa 15(2)b) et du paragraphe 15(3) de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les personnes que propose le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, les personnes sui- Décrets en conseil

Upload: others

Post on 28-Jul-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 173 Wednesday, May 27, 2015 / Le mercredi 27 mai 2015 633

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

APRIL 30, 20152015-84

1. Under subsection 15(6) of the Electricity Act, theLieutenant-Governor in Council acknowledges receipt of theskills and qualifications required of the board of directors as awhole in order for the board to carry out its functions, and theskills and qualification requirements for nominees for the boardof directors position or positions to be filled.2. Under paragraph 15(7)(c) of the Electricity Act, theLieutenant-Governor in Council acknowledges receipt of a de-scription of the recruitment, assessment and selection processesused and the results of those processes.3. Under paragraph 15(2)(b) and subsection 15(3) of the Elec-tricity Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints, fromamong those persons nominated by the board of directors of theNew Brunswick Power Corporation, the following persons as

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

LE 30 AVRIL 20152015-84

1. En vertu du paragraphe 15(6) de la Loi sur l’électricité, lelieutenant-gouverneur en conseil accuse réception des aptitudeset des compétences que doit posséder le conseil d’administra-tion dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonc-tions, ainsi que des aptitudes et des compétences que doiventposséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.2. En vertu de l’alinéa 15(7)c) de la Loi sur l’électricité, lelieutenant-gouverneur en conseil accuse réception d’une des-cription des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélec-tion utilisées et de leurs résultats.3. En vertu de l’alinéa 15(2)b) et du paragraphe 15(3) de la Loisur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme,parmi les personnes que propose le conseil d’administration dela Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, les personnes sui-

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 634 Gazette royale — 27 mai 2015

directors of the board of directors of the New Brunswick PowerCorporation, effective immediately:

(a) Andrew MacGillivray, Saint John, New Brunswick, fora term ending April 15, 2019; and(b) Vicki Wallace-Godbout, Edmundston, New Brunswick,for a term ending April 15, 2019.

4. Under subsection 15(8) of the Electricity Act, theLieutenant-Governor in Council reappoints the following direc-tors of the board of directors of the New Brunswick Power Cor-poration:

(a) Michael Sellman, for a term ending April 15, 2018; and

(b) Dr. Norman Betts, for a term ending April 15, 2018.

5. Under section 16 of the Electricity Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Dr. Norman Betts as Vice-Chair of the board of directors of the New Brunswick PowerCorporation, for a term ending April 15, 2018.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 30, 20152015-86

Under paragraph 2(2)(a) of Le Centre communautaire Sainte-Anne Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints the fol-lowing persons as members of the Community Board ofLe Centre communautaire Sainte-Anne, for a term of threeyears, effective April 30, 2015:

(a) Cécile Paulin-Larocque, Fredericton, New Brunswick;and(b) Claude Haché, Fredericton, New Brunswick.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

MAY 7, 20152015-93

1. Under paragraph 5(a) and subsection 6(1) of the MidwiferyAct, the Lieutenant-Governor in Council appoints SarasVerdam, Vancouver, British Columbia, as a member of the Mid-wifery Council of New Brunswick, effective May 7, 2015, for aterm of three years.

2. Under paragraph 5(d) and subsection 6(1) of the MidwiferyAct, the Lieutenant-Governor in Council appoints Amy Flynn,Bathurst, New Brunswick, as a member of the Midwifery Coun-cil of New Brunswick, effective May 7, 2015, for a term of threeyears.3. Under paragraph 5(f) and subsection 6(1) of the MidwiferyAct, the Lieutenant-Governor in Council appoints VirginiaGillmore, Moncton, New Brunswick, as a member of the Mid-wifery Council of New Brunswick, effective May 7, 2015, for aterm of three years.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

vantes membres du conseil d’administration de la Sociétéd’énergie du Nouveau-Brunswick, à compter de maintenant :

a) Andrew MacGillivray, de Saint John (Nouveau-Brunswick), pour un mandat se terminant le 15 avril 2019; et b) Vicki Wallace-Godbout, d’Edmundston (Nouveau-Brunswick), pour un mandat se terminant le 15 avril 2019.

4. En vertu du paragraphe 15(8) de la Loi sur l’électricité, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau man-dat les membres suivants du conseil d’administration de la So-ciété d’énergie du Nouveau-Brunswick :

a) Michael Sellman, pour un mandat se terminant le15 avril 2018; etb) Dr Norman Betts, pour un mandat se terminant le15 avril 2018.

5. En vertu de l’article 16 de la Loi sur l’électricité, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau man-dat le Dr Norman Betts à titre de vice-président du conseil d’ad-ministration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,pour un mandat se terminant le 15 avril 2018.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 30 AVRIL 20152015-86

En vertu de l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur le Centre communau-taire Sainte-Anne, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeles personnes suivantes membres du conseil d’administrationdu Centre communautaire Sainte-Anne, pour un mandat de troisans, à compter du 30 avril 2015 :

a) Cécile Paulin-Larocque, de Fredericton (Nouveau-Brunswick); etb) Claude Haché, de Fredericton (Nouveau-Brunswick).

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 7 MAI 20152015-93

1. En vertu de l’alinéa 5a) et du paragraphe 6(1) de la Loi surles sages-femmes, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeSaras Verdam, de Vancouver (Colombie-Britannique), membredu Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai2015.2. En vertu de l’alinéa 5d) et du paragraphe 6(1) de la Loi surles sages-femmes, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeAmy Flynn, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), membre duConseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick,pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai 2015.3. En vertu de l’alinéa 5f) et du paragraphe 6(1) de la Loi surles sages-femmes, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeVirginia Gillmore, de Moncton (Nouveau-Brunswick), membredu Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015

MAY 7, 20152015-94

1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Natalie LeBlanc, Fredericton,New Brunswick, as sheriff for the Province of New Brunswick,effective May 19, 2015.2. Under subsection 2(2) of the Sheriffs Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Natalie LeBlanc, Fredericton,New Brunswick, as Chief Sheriff of the Province of NewBrunswick, effective May 19, 2015.3. Under subsections 2(1) and 2(2) of the Sheriffs Act and para-graph 21(1)(a) of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes sections 1 and 2 of Order in Coun-cil 2014-355, effective May 19, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

MAY 7, 20152015-95

Under section 61 of the Judicature Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Crystal Critch, Fredericton NewBrunswick, as a deputy registrar of the Court of Appeal of NewBrunswick, the Court of Queen’s Bench of New Brunswick,Trial Division and Family Division, and of the Probate Court ofNew Brunswick, effective May 19, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

MAY 7, 20152015-96

Under section 19.2 and subsection 19.21(1) of the InsuranceAct, the Lieutenant-Governor in Council appoints the followingpersons as members of the New Brunswick Insurance Board:

(a) Francine Kanhai, Saint-André, New Brunswick, for aterm of three years, effective May 7, 2015; and

(b) Katherine Munro, Saint John, New Brunswick, for aterm of three years, effective August 8, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

LE 7 MAI 20152015-94

1. En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les shérifs, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Natalie LeBlanc, deFredericton (Nouveau-Brunswick), shérif de la province duNouveau-Brunswick, à compter du 19 mai 2015.2. En vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Natalie LeBlanc, deFredericton (Nouveau-Brunswick), shérif en chef de la pro-vince du Nouveau-Brunswick, à compter du 19 mai 2015.3. En vertu des paragraphes 2(1) et 2(2) de la Loi sur les shérifset alinéa 21(1)a) de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque les articles 1 et 2 du décret enconseil 2014-355, à compter du 19 mai 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 7 MAI 20152015-95

En vertu de l’article 61 de la Loi sur l’organisation judiciaire,le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Crystal Critch, deFredericton (Nouveau-Brunswick), registraire adjointe de laCour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la Cour du Banc de laReine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance etDivision de la famille, et de la Cour des successions duNouveau-Brunswick, à compter du 19 mai 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 7 MAI 20152015-96

En vertu de l’article 19.2 et du paragraphe 19.21(1) de la Loi surles assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme lespersonnes suivantes membres de la Commission des assurancesdu Nouveau-Brunswick :

a) Francine Kanhai, de Saint-André (Nouveau-Brunswick), pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai2015; etb) Katherine Munro, de Saint John (Nouveau-Brunswick),pour un mandat de trois ans, à compter du 8 août 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 636 Gazette royale — 27 mai 2015

009370 009370 NB Ltd.033883 033883 N.B. LTD.035688 035688 NB Inc.050057 050057 N.B. LTD.054294 054294 NB LTD.057228 057228 NB LTEE670916 130 Arlington Cres. Inc.500161 500161 N.B. LTD.502016 502016 N.B. LTD.502087 502087 N.B. LTD.502520 502520 N.B. LTD.506026 506026 N.B. INC.507039 507039 N. B. LTD.507132 507132 N.B. Inc.507276 507276 N. B. LTD.509582 509582 N.B. INC.512299 512299 (NB) INC.514720 514720 N.B. Ltd.600771 600771 NB. Inc.601568 601568 N.B. LTD.601695 601695 NB Inc.632666 602002 N.B. LTD.612967 612967 N.B. Ltd.613010 613010 N. B. LTD.613194 613194 N.B. Limited/ 613194 N.-B.

Limitée613432 613432 NB INC.619425 619425 N.-B. INC.619485 619485 NB Ltd.619568 619568 NB Ltée 619568 NB Ltd.619575 619575 N.B. LTD.625999 622428 N.B. Ltd.625997 622431 N.B. Ltd.625996 622433 N.B. LTD.625940 625940 N.B. Ltd.625941 625941 N.B. Ltd.626274 626274 N.B. Ltd.626408 626408 NB INC.632372 632372 N.B. Inc.632506 632506 NB Ltd.638660 638660 NB INC.638798 638798 N.B. INC.638925 638925 N.-B. LTÉE639031 639031 N.B. Inc.639051 639051 NB Ltd.639070 639070 NB Inc.639095 639095 N.-B. LTEE639097 639097 NB INC.639130 639130 N.B. Inc.645062 645062 NB Inc.645068 645068 N.B. Inc.645071 645071 N.B. Inc.645081 645081 N.B. Ltd.645178 645178 NB Inc.645179 645179 N.B. LTD.645358 645358 N.B. INC.651406 651406 NB INC.

651444 651444 N.B. LTD.651501 651501 N.B. LTD.651527 651527 N.B. Inc.651574 651574 NB Ltd.651680 651680 N.B. Ltd.651701 651701 NB INC.651738 651738 N.B. Ltd.651768 651768 N.B. Ltd.651769 651769 N.B. Ltd.651815 651815 N.B. Inc.651855 651855 NB LTD.651871 651871 NB Inc.657913 657913 NB Ltd.657998 657998 N.B. LIMITED658143 658143 N.B. INC.658211 658211 NB INC.658253 658253 N.B. Inc.658318 658318 N.B. Limited664236 664236 N.B. Ltd.664285 664285 N.B. LTD.664502 664502 NB Inc.670807 670807 N.B. Inc. - 670807 N.-B. Inc.670809 670809 N.B. Ltd.670826 670826 NB Inc.670865 670865 N.B. LTD.670888 670888 N.-B. Inc. 670888 N.B. Inc.670999 670999 NB CORP.671003 671003 NB Ltd.671027 671027 N.B. Inc.671102 671102 N.B. INC.671135 671135 N.B. Inc.671154 671154 NB Inc.671175 671175 NB Inc.626088 A & J McNutt Real Estate Holdings Inc.010973 A. & R. MILLER CONTRACTORS LTD.507087 A.L.M. & FILS ENTREPRENEUR LTÉE030510 A.L.S. PETROLEUM SERVICE LTD.664546 Aboriginal Precision Products Inc.664648 Academy of Motivation and

Empowerment Inc.502579 ACADIEN APIARIES LTD.670968 ACETRAK WIRELESS INC.651323 ACIER BRUNSWICK REBAR INC.052252 ADRIEN MELANSON CORPORATION

PROFESSIONNELLE LTEE502531 AGGCON CONTRACTING LTD.601819 Al Thomas, C.A. Professional

Corporation658087 ALLRED DEVELOPMENT LIMITED670848 Altoblum Inc.632481 AMAX HOLDINGS INC.626154 Amoco Financial Centre Inc.601846 Anderson Road Management Services

LTD045267 ANTHONY’S CARPENTER SHOP

LTD.657941 Anywhere Siding Inc.

000653 APREN AND ASSOCIATES LTD.671025 ARCH Properties Ltd.671114 Archer Custom Woodwork Inc.052160 ATLANTIC BUILDING

CONTRACTORS (1992) LTD.607447 ATLANTIC DISCOUNT IMPORT

PARTS LTD.645029 Atlantic Sealers Inc.664312 Atlantic Triple AAA Investments Inc.651525 Aurora Holdings LTD.645109 Axis Communications Inc.052189 B & B HOLDINGS LTD.509551 B. C. ELECTRIC INC.049397 B. WISE INC.670805 Backoffice724 Solutions Inc.607403 BARACHOIS TIRES LTD./LES PNEUS

BARACHOIS LTÉE645114 BCM Distributions Inc.645057 BEARDSWORTH MEDIATION INC.638793 BERKSHIRE BROMAN

CORPORATION657871 Betcapo Sports and Gambling Inc.505103 BIOKINETIC PROSTHETICS INC.651532 BJ MICBRY CONSULTING INC.045158 BLEUETIERE NORD-EST INC.502671 BLUE MOON MOTEL LTD.639141 Blue Olive Inc.002070 BONDED BUILDERS CO. LTD.651708 BRIDEAUstate Inc.638862 BRO-FAB INC613327 BULLEID HENDERSON

PROFESSIONAL CORPORATION035673 BURTON EQUIPMENT RENTAL &

TRUCKING LTD.042167 C. DEMMINGS & SON LTD.671209 CACHAL PROPERTY INVESTMENTS

INC.671105 CANUTOUR SOLUTIONS

INCORPORATED057291 CASCO BAY AQUACULTURE LTD.601818 Cathy Simon Professional Corporation003266 CENTRAL KINGS RECREATIONAL

COUNCIL LIMITED664598 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

L’IMAGINAIRE INC.626493 CG Investments (2006) Inc.001130 CHAMI LTEE512142 Charlie’s Roofing & Siding Inc.638675 Christien Arsenault Rental Properties Inc.670824 CHROMATIC ENTERPRISES INC.509523 CHUMLEY’S EATERY LTD.671186 CISM Overseas Inc.670847 CLOUTIER FORESTRY INC.670940 Concord Enterprise Inc.607245 CORMIER LUMBER LTD.512146 Cormier Mécanique Plus Ltée

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialeset d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-ciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations sui-vantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corpo-rations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la datede la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeurpourra dissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and tocancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve thecorporations.

Business Corporations Act

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 637 Gazette royale — 27 mai 2015

507214 Corporation Professionnelle Dr. Jean-Bernard LeBlanc Professional Corporation

607474 Cory Guimond Holdings Inc.004385 COTE’S FURNITURE LTD.-MEUBLES

COTE LTEE.030524 COURTENAY TRAILER RENTALS

LTD.004449 COWIE & SON LTD.514826 CRAZY CANUCK LTD.091891 CROWN CONSTRUCTION CO. LTD.004546 CRYSTAL ESTATES LIMITED638717 CVU Software Ltd.670946 CYNOGE Holdings Inc.638855 DAYBREAK SENIOR ACTIVITY

CENTRES LTD.670843 DBM Logging Ltd.514653 Decoma Holdings Ltd.664541 DEGRÂCE ARPENTAGES

CONSTRUCTION SURVEYS INC.671046 Denco B.C. Construction Ltd.507140 DENCO LOGGING LTD.651336 Deveau’s Framing & Renovations Ltd.670856 Diamond Development Inc.651516 DOFO AQUA-PRO FISHERIES INC.005083 DOFRED DEVELOPERS LIMITED005096 DOIRON STATION-SERVICE LTEE632395 Dr Denis Pelletier Corporation

Professionnelle Inc.651714 Dr Justine Musemba C.P. Inc.651858 Dr. Adnan Habib Professional

Corporation658237 Dr. Alexander D. Wishart Prof. Corp.671085 Dr. D. Joshua Mayich Professional

Corporation632405 Dr. Erik F.C. Klein Professional

Corporation042333 Dr. F.R. Richards Holdings Ltd.612992 Dr. Roger Bashala Corporation

Professionnelle Inc.632606 DRL Auto Ltd.670796 DRS Trucking Ltd.664424 DSV HAULING LTD.033992 DUBE BROS. EQUIPMENT LTD. -

EQUIPEMENT DUBE ET FRERES LTEE.

033954 DUCLOS HOLDINGS INC.054372 DUNBAR VENTURES INC.651842 DUTCH VALLEY ACRES INC.619821 Dynamic Drywall Inc.601968 E & S Forest Services Ltd.058037 E. BERUBE & SON ENTERPRISES

LTD./E. BERUBE & FILS ENTREPRISES LTEE

658362 EAST ROUTE SHIPPING AND TRADE LIMITED

505121 EASTWIND SPECIALTY VENEERS LTD.

042217 ECO-HOUSE INC.658115 École Moncton Montessori School Inc.664367 Ecoluz Canada Inc.507294 ED’S VARIETY LTD.502529 EMILE C. LEBLANC & FILS

TRADING LTEE/EMILE C. LEBLANC & SONS TRADING LTD.

632700 Épicerie Levasseur Inc.512265 ETC-Entrepreneurship Training

Consulting Inc.613223 EvacuAir Inc.626375 EXDY Synergy Inc.502591 FAIRFIELD-OGDEN HOLDINGS LTD.613278 FERME DU DIAMANT INC.644995 FOKISOFT TECHNOLOGIES INC.658369 FORBURG LOGISTICS LTD.658198 FOYER STE-ANNE-DE-

MADAWASKA INC.670763 Frame Rates Inc.632452 Frankmax Holdings Ltd.

651528 FREDERICTON RECYCLING AND REDEMPTION INC.

658045 FRENCH LAKE LOGGING INC.645221 Fundy Solar Ltd.664365 Futuretech Builders Inc.670771 G & G Nuclear Ltd.049978 GARY JOHNSON INC.664719 GB INVESTMENTS INC.034017 GEMSCOPE LTD.639110 Gestion J.D.G. Holdings Inc.658192 Ghislain Foresterie Inc.613382 GILANAP CONTRACTING LTD.512164 Gilbert Welding Ltd.601640 GinoMax Holdings Inc.502444 GISOTAL LTD.658208 GITC INVESTMENTS & TRADING

CANADA LTD.509528 Gîte Toutes Saisons Inc.651698 GOLDENLAW ENTERPRISES LTD.671065 GOODWARE SOLUTIONS INC.505105 GRAND LAKE FORESTRY INC.047777 Grass Home Ltd.664368 Green Bay Power Generation Holding

Limited658147 Green Feet Lawncare Ltd.054822 GREWAL PARTNERSHIP LIMITED020263 GUIMOND BOATS LTD.645269 Gunn Holdings Ltd.505071 H.E. MERCHANT AND SONS LTD.670822 Halifax Citrus Company Ltd.050142 HANWELL AUTOBODY LTD.645195 Happy Hopyard Inc.601671 Hartlen Homes Ltd.607456 HAWKBURN ENTERPRISES LTD.671058 HC LOGISTICS INC.670755 HD Co-Ed Fitness Center Ltd.670754 HD Group Ltd.035622 HICKEY’S TRUCKING LTD.032177 HILLTOP CONTRACTORS LTD.500288 HOLSTE TRANSPORT LTD.664237 Hurst Paving Inc.632283 i communications Inc.619524 I Countability Corp.671184 IBSP International Inc.670928 Ignifera Records Ltd.042268 IMMEUBLES CADO INC./CADO

REALTY INC.658116 Immeubles Raymond & Yvette Basque

Inc.651644 Impact Painting Inc.507290 Info plexxus Inc.632507 Info-Sac Distributors Inc.601705 IRS Holdings Ltd.607100 J & M Rentals Inc.045278 J & S GILLIES OPTICAL INC.619448 J. Bradley Enterprises Inc.035645 J.M.R. SPORT LTEE500229 Jane Maillet & Associé, Corporation

Professionnelle Inc.671033 JT FAMOUS LEBANESE FOOD INC.613251 Jumpai Maritimes Inc.670806 Justin J. Robichaud C.P. Inc.651360 KAAT Enterprises Inc.058035 KEITH’S FUELS LTD.626097 L & M Developments Ltd.670930 L’AUBERGE DES TROIS PIGNONS

INC.657912 L.J. Rénovations Experts Inc.502667 L.P. CHIASSON SERVICE SANITAIRE

LIMITEE001749 LA BELLEVUE COMPAGNIE LTEE -

LA BELLEVUE COMPANY LIMITED

664547 LA VILLA D’AURÉLIE INC.607097 LARA HOLDINGS LTD.664305 Le Domaine Bellerive 2012 Inc.607397 LE PETIT MAGASIN LTÉE030478 LEAMAN INDUSTRIES LTD.638706 LEBBAS HOLDINGS INC.

626116 LeBlanc Transmission Inc.639016 Legault Sabean Engineering Ltd.664540 LES BLEUETTIERES YVES

LAROCQUE INC.005805 LES ENTREPRISES ALDORIA

BOUDREAU LTEE005833 LES ENTREPRISES EDMARC LTEE049633 LES MOULES G.L.C. LTEE - G.L.C.

MUSSELS LTD.664583 Les Productions Ciné Atlantik Inc.625944 LGC Service of Glass Machinery Inc.671179 LIFETIME 360 HOME

ACCESSIBILITY SOLUTIONS INC.619621 Long Marsh Creek Holdings Inc.651448 M & B Holdings Inc.607334 M. M. CORMIER ET CIE (2003) LTEE645405 M.W. Naugle Holdings Inc.035705 MACMULLIN’S FARM LTD.051953 MANOIR BASQUE LTEE/MANOR

BASQUE LTD.645263 MANOIR DU NORD INC.020257 MASH ENTERPRISES LTD.645142 Mason Financial Services LTD.045331 MCCOUBREY HOLDINGS LTD.645017 Medrunner Health Solutions Inc.010839 MELANSON SEAFOODS LIMITED645270 Melnychuk Holdings Ltd.509701 METAFIT INC.651833 MILLENAIRE WELLNESS LTD.010981 MILLER’S WELDING SUPPLIES LTD.039603 MIRAMICHI FOUR SEASON

OUTFITTERS LTD.671062 MisSamdals Inc.638889 Mitchell’s Garage Inc.058007 MITTON CONTRACTING LTD612862 Modern Business College (Fredericton)

Ltd.619803 MONTAGNE JEUNESSE (CANADA)

CORPORATION644983 MOORE PROPERTIES &

RENOVATIONS LTD.651776 Mountain Range Ranch Ltd.670860 Munro Computer Sales & Service Ltd.632310 N&B Plumbing & Heating Ltd.514681 NBAPC Development Corporation619369 New Vision IT Inc.658346 Night Palace Ltd.638641 NLC Enterprises Ltd.613337 Old World Masonry Ltd.664329 Onboardly Media Inc.670784 One Touch Heat & Cool Inc.638740 Ottoman Trucking Ltd.057930 PASSEKEAG HOLDINGS INC.514722 Phoenix Plastik Inc.013150 PIRIE POTATO COMPANY (1973) LTD.052265 PIZZA TWICE INC.632370 Plant Project Services Inc.619539 pod consulting group inc.626287 PRAVO INTERNATIONAL LIMITED047481 PRINTING PLUS LIMITED509603 PROVINCIAL SECURITY AND

INVESTIGATION SERVICES LTD.626339 R & D Price is Right Stores Ltd.645265 R & R Holdings (2010) Inc.010717 R. F. MASON LTD.607043 R. GAUNCE ENTERPRISES LTD.626365 Rahmat Groceries Ltd.505063 RAYCO WHEELS & CASTERS LTD.670835 RBS Industrie Import/Export Canada Inc.670873 Redsky Business Solutions Inc.664501 Restaurant Villageois Baie Ste. Anne Inc.664566 Richbay Tech Development and Trading

Corp.632525 Rideout Water Services Limited514813 RIDGERUNNER LOGISTICS LTD.607084 RILEY ENVIRONMENT LIMITED057921 RIVER VALLEY CRANBERRY

COMPANY (1994) INC.671144 River Valley Technologies Inc.

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 638 Gazette royale — 27 mai 2015

607209 RIVERS EDGE VENTURES INC.645119 Riverside Park Investments Inc.050031 RIVERSIDE PROMENADES LTD. -

LES PROMENADES DE LA RIVE LTEE

670836 Riverview Energy Centre Inc.613357 Rockwood Software (2004) Ltd.671157 ROGERSVILLE CONVENIENCE INC.039618 RON NOWLAN ENTERPRISES LTD.664156 RONREG HOLDINGS INC.664732 Russell Excelsior Properties Inc.671076 RY Interlock Inc.012843 S. PASCON GENERAL MASONRY

LTD.658213 S. Pike & Son Trucking Inc.607357 SAINTE MARIE HIGHO (2003) INC.664249 SALIENT TRAINING SOLUTIONS

INC.670797 SAMIMI’S CONVENIENCE NEW

MARYLAND INC.658393 Schillco Inc.052011 SHARED’S INC.657963 Silver Fox Productions Inc.

611385 Simmental Farms (N.B.) Ltd.644976 SIMPLY MORTGAGES LTD.658177 SKLS Bleuetière Ltée507160 SMALL TIME PROPANE LTD.664584 Snake Island Inc.045251 SOMMERVILLE FLOORING LTD.645070 SPACESHIP HOBBIES LTD.626129 Spineco Investments Ltd.607262 ST. ANNE INDUSTRIES LTD.015618 STILES BODY REPAIR LTD.509748 Storage Systems Construction corp.658011 Sudden Service Plumbing Ltd.664506 SUMMIT COATING INC.047769 Supreme Garage Door Ltd.502696 SURGICURE CANADA INC.626131 Team Whittaker Inc.039617 TECTURA INC.671123 TELRAD CANADA LTD.020102 Ter-i-o Holdings (BSA) Inc.502586 TERRAMINE DEVELOPMENT INC.632279 The Canadian Make-belief Ltd.619654 The Fisherman/Le Pêcheur Inc.626134 THE MORTGAGE MAKERS INC.

645471 The Scoreboard Weekly Ltd.632207 The Urban Almanac General Store Inc.619678 Thériault Contracteur Ltée639027 Tied In Pipeline Services Inc.658329 TOM DIAMOND RENOVATIONS LTD.626304 TOM McGINN TOURS LTD.619723 Trendy Services Inc.037564 TRIPLE H. CONTRACTING LTD.658370 UNITED PRODUCTION DELIVERY

LIMITED.016589 UPPER KENT LIME WORKS LTD.014822 V.J. SAVOY LTD.512195 Vidar Holdings Limited001980 W. P. BLACK & SONS LTD.671075 Webrotator Technologies, Inc.638633 WESTBAY HOLDINGS LTD.645266 Wheelbase Holdings Ltd.632637 White Wave Ltd.500377 WOBBO HOLDINGS LTD.021428 YOUNGCO LTD.645137 Zip Zag .ca Inc.

670910 100464 PEI Inc.664578 1772174 Ontario Inc.658291 2281428 Ontario Inc.073791 2636-4588 QUEBEC INC.619685 3475425 CANADA INC.664579 4358376 Canada Inc.658030 6749976 Canada Corporation671100 8347956 CANADA INC.671174 8560854 Canada Inc.017086 ART INSTRUCTION SCHOOLS, INC.632386 BGS Training Incorporated077247 BOND STREET COLLECTIONS

INCORPORATED077760 BRANDYWINE GLOBAL

INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA), ULC / GESTION DE PLACEMENTS BRANDYWINE GLOBAL (CANADA), S.R.I.

664554 Cambridge Insurance Brokers (Preston) Ltd.

619348 CARESTREAM MEDICAL LTD.658137 CONCORD CONCEPTS INC.658072 CONTECH ENTERPRISES INC.657979 Direct Lab Atlantic Inc.077774 Fenêtres R.L. Inc.632592 Flying J Canada Transport Inc.658240 GAZ PROPANE RAINVILLE INC.664614 Great Atlantic Resources Corp.664461 Integrity First Telesolutions Inc.619390 JAMESON BANK601687 JELD-WEN OF CANADA, LTD.664351 LawQuest Canada Incorporated664495 Les Rôtisseries St-Hubert Canada Inc

St-Hubert Bar-B-Q Canada Inc.632520 Lindsay & Associates Fire Services Inc.619406 MAPCOMM INC.

670863 Marish Tech Inc.018063 MELANSON FOODS CORPORATION670985 MYOFFICEPRODUCTS, LLC658093 Nexsys Financial Inc.651710 NUMIS NETWORK, LLC077738 O’Brien Installations Limited671137 Penguin Canada Books Inc.651402 R&Q Risk Services Canada Limited658239 SERVICE D’ÉCHANGE RAPIDGAZ

INC.619506 TOLL CROSS SECURITIES INC.658135 Tri-Mech Ventures Inc.072768 VINCELLI HOLDINGS INC./

GESTIONS VINCELLI INC.664739 WARNER CHILCOTT CANADA CO.

____________________

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, asthe said corporations have been in default in sending to the Directorfees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, theDirector may cancel the registration.

____________________

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir auDirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans laGazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desditescorporations extraprovinciales.

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 639 Gazette royale — 27 mai 2015

000862 A.P.V. ENTREPRISES (1998) INC.664767 ASSOCIATION ÉQUESTRE DU

NORD-OUEST INC. / NORTH WEST EQUESTRIAN ASSOCIATION INC.

651808 ASSOCIATION OF N.B. CEMETERIES INC.

639049 Association of Neuropsychologists of New Brunswick Inc. Association des Neuropsychologues du Nouveau-Brunswick Inc.

010281 BARREAU DU MADAWASKA INC./MADAWASKA LAW SOCIETY INC.

003351 CENTRE RECREATIF DE ST. ARTHUR INC.

023797 CENTRE-VILLE CARAQUET INC.613087 Classes-relais de la Péninsule Acadienne

Inc.671140 CLUB DE VOILE - BAIE DE

CARAQUET (2013) INC.024621 CLUB LOISIR DE LA RIVIERE

CARAQUET INC.023130 CLUB SKIROUE INC.023472 CONSEIL POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES COMPÉTENCES DES ADULTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

024026 DOUGLAS AVENUE CHRISTIAN CHURCH INC.

664422 Église Cité de la Grâce Inc.020165 FESTIVAL DES RAMEURS INC.

664569 FREDERICTON MIDGET AAA SCHOLARSHIP FUND ASSOCIATION INC.

671043 Gala de la PME Inc.023802 KENNEBECASIS VALLEY MINOR

BALL ASSOCIATION INC.024442 KESWICK RIVER TRAIL BLAZERS

SNOWMOBILE CLUB INC.645157 L’Association des familles Arsenault

Family Association Inc.670971 La Famille Caissie, Caissey, Quessy,

Roger Family Inc.015332 LA SOCIETE HISTORIQUE DU

MADAWASKA INC.619548 LAKE DIGDEGUASH ESTATES INC.021624 LE CLUB D’AGE D’OR DE

ST-PHILIPPE INCORPOREE012590 Le Club Optimiste Moncton-Dieppe Inc.022930 LE JOUGARDI INC.011853 LEARNING DISABILITIES

ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK INC. \ TROUBLES D’APPRENTISSAGE-ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

025132 LOBSTER STORAGE (N.B.) ASSOCIATION INC.

632630 Miramichi Forward Inc.011236 MONCTON AND DISTRICT MINOR

BASEBALL ASSOCIATION INCORPORATED

021617 MONCTON COIN CLUB INC.

011259 MONCTON GUN CLUB, LIMITED626033 MUSQUASH ATV CLUB INC.638903 MYNEXIA INC.012405 NORTHUMBERLAND COUNTY

WOODLOT AND PULP PRODUCERS ASSOCIATION INC.

607076 OFFICE DU TOURISME EDMUNDSTON MADAWASKA INC.

013957 REXTON LIONS CLUB INC.632273 ROTARY CLUB OF PERTH-

ANDOVER, INC.638950 SSHS Sport & Cultural Association Inc.645343 THE CHARLO HATCHERY

FOUNDATION INC.639125 The Elizabeth Fry Society of Saint John,

N.B. Inc.024027 THE MONCTON HOSPITAL FIRST

STEPS CHILD CARE ASSOCIATION INC.

671009 The NBFirst Foundation for IT Education Ltd.

096620 THE SHEDIAC RIVER FISHING CLUB COMPANY,(LIMITED)

022928 THE ST. MARTINS BEAUTIFICATION SOCIETY INC.

021642 THISTLE-ST. ANDREWS CURLING CLUB

025319 Tire à l’arc Moncton Archers Inc.638919 Tumblehome Paddlers Inc.645188 VÉLO EDMUNDSTON INC.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provincialesSoyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa-gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertude l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publicationdu présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudrelesdites compagnies.

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companiesTake notice that the Director under the Companies Act has made a de-cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.Please note that 60 days after the date of publication of this Notice inThe Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Companies Act

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, envertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétésen nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificatsd’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé defaire enregistrer des certificats de renouvellement conformément àl’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selonle cas.SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registrairepeut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nomcollectif et certificats d’appellations commerciales.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of thecertificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-nexed hereto and the certificates of business names of the businessesset forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the saidfirms and businesses have failed to register certificates of renewal inaccordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),as the case may be applicable, of the said Act.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date ofthirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-trar may cancel the registration of the said certificates of partnershipsand certificates of business names.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 640 Gazette royale — 27 mai 2015

612458 A.R.C. CARPENTRY REG’D650505 Actus Law Droit650588 East Coast Imports611710 FRAISIÈRE CHEZ PAT ET

ALPHONSINE650360 G & D Maillet Trucking

612644 Geo Littoral Consultants611752 GILLIS COVE COTTAGES618850 Klondike Liquid Gold650289 Larsen’s Log Lodge650381 Le Groupe XÉNO650549 MINH’S STORE

650311 Pride Concrete Finishing650761 Rawja Security and Investigation649962 RPM ENTERPRISES650850 STATIONERY PLUS650450 Target Lock Studio650844 Wigwam Sea Products

341492 A & A AUTO650742 A & S CREATIVE612091 A & W ANTHONY SERVICES650655 A Buyer’s Choice Home Inspections -

Fredericton650756 Absolute Serenity Spa & Wellness650206 Acadia Consultants and Inspectors612513 ACADIA LANDSCAPING650292 AE Jewelry611771 Aerus Electrolux650506 ALP Enterprises650323 Amin Painting650281 Aniconic Screenprinting650659 ANIDRAW ANIMATION STUDIOS611879 ANITA’s Elegant Nails612710 Anita’s Foot & Health Care650356 AppSavvy Training Solutions346914 April’s Electrolysis650627 Aqua Natural Store650259 Arthur Wood Consulting650321 AS Telecom612690 ATLANTIC MOTOPLEX650685 Atlas Financial Planning650603 Audiologie Péninsule610858 AUDREYS GREENHOUSE612167 Auto Brokers Select.com650774 B & B General Services612827 B R COMPUTER SALES650397 B&B Thompson Carpentry650564 Beam Security Systems650410 Bedford Sherrard Construction618692 Beers Roofing611818 BeeWebConnected650317 Bellmac Business Development650643 Bernard Mechanical Enterprises650412 Big Fish Media649659 Bikes Apart650465 Black Hat Poker Supplies649550 Blue Leaf Massage Therapy612455 Boucherie Guy Pelletier612225 Bourque Auto Sales650826 Bradley Israelson Roofing612264 BRUN-WAY GROUP650513 Bulldog’s Gym650487 BYRON CAPITAL MARKETS650720 C & L Gypsy Trading & Co.344273 C. M. POWER WASH650232 CA-ADS2TXT650509 Caissie Aquaculture650152 Camp Stanton650348 CAROLE FORBES TECHNIQUES611896 Castell Aquaculture Nutrition Consulting650775 CEDARWOOD LAWN CARE624963 CENTRAL ELECTRICAL SERVICES650660 CHAOTIC CUCUMBER VENTURES650436 CHARLIE LEBLANC

CONSTRUCTION650602 Charlies Parking Lines650408 Chaterie & Chenil du Diamant612116 Choix du Sommelier Selection632086 CIT VENDOR FINANCE, CANADA612832 Clan MacKinnon of New Brunswick

650706 Clark’s Landscaping650443 CLINIQUE PRO MASSAGE650809 CLUB SOHO650740 Clutter Control By C. Brennan612697 Coastal Engineering Services612499 COMPLETE TREE SERVICE650504 correspondance Lire-Ami349470 Country Bee Candles617927 COURTESY CONVENIENCE GAS

BAR611868 Crazy Paint Horse Ranch612446 CREDIT BUREAU COLLECTIONS612103 Cuckoo’s Nest Aviary631675 CYBECTEC310030 D & P FURNITURE612475 D.E.K. and Associates Construction

Consultants650314 Dan Cormier’s Roofing338553 DARLENE’S OLD COUNTRY

BAKERY & TEA HOUSE650249 Dashing Aquatics650572 DAVLIN CONSTRUCTION612163 DEALER SPECIALTIES650827 Dennis Kelly Nuisance Wildlife & Traffic

Control618458 DESTINATION: PLANS SANTE-

VOYAGE618456 DESTINATION: TRAVEL HEALTH

PLANS650772 DLC Priest Financial650593 DNB Green Solutions328689 DOCUMENT SEARCHING SERVICES650736 DON COREY CONSULTING

SERVICES650816 DP Construction612564 Dream Nails, ongle de Reve650684 E.T. Earth Movers650423 EagleSpirit Journeys612390 East Side Tire Centre611949 Eastcoast Pharmacy650733 Edgett’s Detailing650442 ELEVATE HR CONSULTING

SERVICES649866 Elmwood Chiropractic Clinic612771 ELUSIVE SKATE AND SNOW650745 Entre Bonnes Griffes650507 Entreprise P.F. Enr.618242 Entreprises MARS Communications

Enrg.650357 Eudora Day Spa & Wellness Studio644436 EVO Performance Store (2009)650788 Excel Therapy Clinic650309 Feel the Groove T-Shirts346949 FERME Y.C. THOMAS ENRG.650240 Final Expressions Funeral Planning612487 FIRST CHOICE FINANCING612349 FLEURISTE BELLA FLORA650822 flowerfolks650313 FMC Wood Products648188 Food Safety Training New Brunswick650667 FourEver Design650825 Fred’s Lawn Care

611694 Freestyle “The Hair Shop”333410 FRESH CHOICE650484 FROSTY LODGE650511 FUNDY HIGHLANDS650533 G. BURTON DATA SOLUTIONS650370 G.O. Bookkeeping612112 GARDEN PRO LANDSCAPING (2004)346909 Garderie Polichinelle650479 GATEWAY PROPERTY

MANAGEMENT618509 GENERAL MILLS618510 GENERAL MILLS BAKERIES AND

FOOD SERVICE612171 Get R Done Renovations650307 Gillian Goldie Design650776 GLOBAL PROPERTY INSPECTIONS301973 GRANNAN’S SEAFOOD

RESTAURANT & OYSTER BAR650585 Graves Geo Thermal650217 Grays Country Care650457 GREEN LIVING HOME SHOW618174 Grizzly Jim & Altas Outfitting644404 GT Vehicle Inspection Services650630 Guerrette IT618062 GUYS & GALS HAIRSTYLING REG’D650361 Happy Home Insulators612709 HAPPY SCISSORS644162 HARMONY HAIR SALON650502 HAZELDEAN SALES644412 Hidden Brook Solutions649751 Hillsborough Auto Leasing650661 HOSPITALITY TRAINING NEW

BRUNSWICK612735 HOTEL MONCTON650606 Imara Consulting650674 Island Complete Repair & Renovation650551 J & M Pharmacy Relief650253 J. L. G. WELL BEING650793 J.P. General Mechanics650403 Jason Kelly Trucking650624 Jean-Paul Boudreau Photographie649716 Jean-Yves H. Construction650387 JOHNIC CONSTRUCTION612123 Juke Box CD’s612563 K & R TRUCK AND AUTO SERVICE650570 K. LANDRY MECANIQUE650184 Kacher Design Intérieur650264 KAYAKS2GO644425 Kings County Plumbing and Heating619239 Kitchen Helper612398 KUSTOM GENERAL CONTRACTING650441 Kyle McCormick Painting650547 L’inVINcible - Agence et Représentation

de Vin650182 L2 - RPA / L2 - ARP650981 LA BELLE ENTERPRISE650710 La coupe élégante pour homme611970 LA PTITE FRITURE ENRG.650414 Lake Marine and Machine612416 LANDCOR ERECTOR650153 Last Frontier Resorts650342 Lavage d’Auto Super 2010

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

_____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 641 Gazette royale — 27 mai 2015

650486 LC - Tenue de livre650584 Lecouteur Rénove Tout650467 Leger Custom Blinds Services650691 Leger Environmental341737 LES SERVICES LINGUISTIQUES JL611961 Li & Associates Consulting612172 Lifetime Homes650515 LIVING GREEN HOME SHOW644433 LIZEKO BOUTIK650322 Lloyd English Consulting650456 LM Uniformes650763 Loftus Logistics650476 LOREX MAÇONNERIE612791 Lou Lou’s WEDDING GALLERY650225 LOYALIST HOME INTERIORS650444 LT Curbs650325 Lynda Branch Comptabilité & Documents

- Lynda Branch Accounting & Documents

650404 LYNNSBROOK WOODWORKING330922 M & M MEAT SHOPS650725 M. L. Finish341875 MACDONALD FUNERAL HOME650478 MAGIC MATCH650280 Maltais Bookkeeping618052 MAMA’S PUB341602 MARI-TECH CONTROL SYSTEMS650802 MERCO RV SALES325862 MEXICALI ROSA’S650730 MIKE BURCHILL PRODUCTIONS316487 MILL AUTO PARTS611938 MINI GOLF CARAQUET612830 Miramichi City Eavestroughing349182 MIRAMICHI SPEED & CUSTOM617929 MOUNTEAGLE OUTFITTERS650061 Mr. Lee’s Cleaning650815 Natshi Designs650367 Natural Touch Naturotherapy/

Naturothérapie650482 Noble Gates Book Store618075 NOR-WEST SIDING618107 NORTHERN HARRIER SCIENCE326469 NORTHRUP HOMES300759 NORTHRUP QUARTERHORSES611114 O BO COFFRET ENG650516 O’Daley’s Pub644411 On the Sweet Side Desserts650676 ONYX by Aimee650271 ORDIMANIA SERVICES

INFORMATIQUES346722 OROMOCTO PHYSIO CENTRE650729 PAINTED HORSES PAINTING AND

SIDING650644 Papa’s Nuts650804 Parise Photographie650561 Patterson Toyota612569 Paul St-Coeur PLANCHERS Bois Franc612246 Petagree Dog Grooming650845 PETERBILT ATLANTIC PACLEASE650419 PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE650421 PHILIPS HEALTHCARE650418 PHILIPS HOME HEALTHCARE

SOLUTIONS CANADA

650422 PHILIPS LIGHTING650439 PHLEBOTOMIE No-Ri618511 PILLSBURY601166 PILLSBURY CANADA618125 Pitou’s Fancy Paws611808 PITRE’S GARAGE AND AUTO

SALVAGE650512 pixelles design650848 Play Space Consulting612372 Player Development Soccer Academy644438 PLUMWESEEP CYCLE &

RECREATION612345 Pop’s Bar650540 Pottruff & Smith Insurance Brokers650840 POWER BUILT CONSTRUCTION611480 PRESIDENT CHAMPAGNE

COMPANY650771 Priest Financial Group650607 Primo Advantage Construction612259 Priority Landscapes650312 Pro Equipment Repair650252 PRO LINE HOBBIES650838 PRO-ACTIVE AUTO REPAIR650268 Qoeqos Solutions650373 Quality Landscaping and Property

Maintenance611921 Quest & Dunlop Associates650219 QUICK PICK DELIVERY612667 R & M FISH SHACK650247 R.J.M. Plus Vente de vehicules hors route650688 RAINSTONE MASONRY650286 RALLYE MOTORS HYUNDAI650287 RALLYE MOTORS MITSUBISHI644426 RC INNOVATION315044 READES SALES AGENCY612006 RESTIGOUCHE APARTMENTS650251 RHEAL DOUCET CONTRACTING344420 RITEWAY TRUCK RENTALS612776 RIVER TRAIL BED & BREAKFAST650275 RIVERSIDE MOTORS650290 Rock Maple Landscapes650256 ROCKWELL INVESTMENTS650803 Roger Martel Roofing612031 Rokon Motorcycle Sales & Service650389 Romantica Nocturnis Clothing649901 Rôtisserie Le Moussaillon610735 RYAN & CO. ART & CONCEPT650616 Sacoche Plus650302 Saint Jacques K9 Centre612220 SAINT JOHN ALE HOUSE611749 SALISBURY K-9 CENTER618690 Salon 48650415 SALON BEAUTE EFFET MER650611 Salon Bohème650583 Savour Décor650789 SCA Financial Services650646 SERVANDA GEOMATICS650266 Shaolin Kungfuzen Academy650246 Shariton Home Maintenance650025 Shurlook Homes Property Inspector650550 Signature Nails & Esthetics612484 SKIPPER JACK’S SEAFOOD & GRILL

HOUSE

612013 Specialty Tech-Shoppe650694 ST Homecare & Firewood644408 ST-CHARLES ALTERNATOR650810 Star Advantage Construction650749 Stitch & Brush Home Decor650553 Straight Line Accounting650432 StraightLine Communications331294 STUDIO ON THE MARSH650651 SUNNY CORNER’S ISLANDVIEW

B & B INN650355 Sunnyside Lawncare650783 SUSAN MARR HOME CARE

SERVICES650587 SUWANNA RESTAURANT650704 Sweeney Marine & Performance650461 T-Zone Health Associates650374 TAPESA Media322435 TASTEFULLY YOURS FLOWERS &

GIFTS618171 Tattersall’s Consultant650454 TBS eXtreme Roof & Renovations650757 Terpa Distributors638622 The Ashford Group346651 THE CHOCOLATE MUSEUM649939 The Diner Down Under650380 The Graphic Design House650459 THE GREEN HOME SHOW612374 THE HEALTHY TOUCH650617 The Little Armadillo Print Shop319466 THE LUNAR ROGUE PUB650843 THE MEETING PLACE CHURCH333350 THE QUILTING CONNECTION650557 The UPS Store #81650658 The Well Pub612373 THE WILLOWS BED & BREAKFAST650496 Thomas EOD Consulting and Security650300 Tim Lutes Training Centre338774 TINGLEY’S HEATING612238 Tinwood Construction612156 TNS CANADIAN FACTS650248 Todd Gamblin Construction &

Renovations612740 TOUGH RIDERS BIKETHON ENR.650483 TRASH AWAY618435 TRIMAC TRANSPORTATION

SYSTEM611977 VALUE STAR DISCOUNT CARD &

SERVICE650379 Veranda Concept346754 VIVA INTERNATIONAL GROUP650747 W. Jackson Construction650205 W. N. Horner & Associates650365 WATSON SEPTIC TANK SERVICES650518 Way of Wellness Lifestyle Strategies611628 WoodTrax650762 WORKLIST612480 X-TREME DANCE STUDIO650634 Youngster’s Child Care - Musquash

Center349185 YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS

PERENNIALS

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 642 Gazette royale — 27 mai 2015

VIVA STUDIO & SPA BY TINA INC. Fredericton 682248 2015 04 22

PECHERIE A. F. NO 1 LTEE Miscou 682436 2015 04 30

Burley Electric Ltd. Saint John 682437 2015 04 30

682441 N.B. LTD. Saint John 682441 2015 05 01

ATLANTIC CANADA LOBSTER EXPORT INC. Dieppe 682442 2015 05 01

682443 N.B. Inc. Moncton 682443 2015 05 01

GH Brown Chemistry Services Ltd. Bayview 682444 2015 05 01

682446 NB Inc. Fredericton 682446 2015 05 01

682447 N.B. Inc. Mayfield 682447 2015 05 01

GESTION PMC CLAIR INC. Clair 682449 2015 05 01

LUTES LOGGING LTD. Monteagle Road 682451 2015 05 01

682452 NB LTD. Riverview 682452 2015 05 01

682453 NB LTD. Riverview 682453 2015 05 01

BRENT KNOWLES ENTERPRISES INC. Salmon Beach 682454 2015 05 01

RVCS- Recreational Vehicle Consignment Service Ltd. Lincoln 682461 2015 05 01

Nelson Cole & Son Trucking Ltd. Harvey 682468 2015 05 01

JL MICHAUD ROOFING GROUP INC. DSL de Drummond /LSD of Drummond

682482 2015 05 04

682483 NB LTD. Saint-Jacques 682483 2015 05 04

Savoie Plumbing & Heating Inc. Moncton 682486 2015 05 04

CJ Woodland Gardens Inc. Indian Mountain 682489 2015 05 04

Green Timber Logging Inc. Royalton 682491 2015 05 05

682492 NB LTD. Moncton 682492 2015 05 05

Ray’s Coach House Food Co Inc. Saint John 682494 2015 05 05

LES RESIDENCES CODY INC. DSL de Drummond /LSD of Drummond

682495 2015 05 05

Junction Harvesting Ltd. Sackville 682498 2015 05 05

682500 NB LTD. Dieppe 682500 2015 05 05

682501 N.B. Inc. Riverview 682501 2015 05 05

Appalachian Chaga Inc. / Chaga des Appalaches Inc. DSL de Drummond /LSD of Drummond

682502 2015 05 05

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 643 Gazette royale — 27 mai 2015

682506 NB INC. Rivière-à-la-Truite 682506 2015 05 05

Express Plomberie Ltée Caraquet 682509 2015 05 05

Bothwise Consulting and Service Co. Ltd. Moncton 682514 2015 05 06

S.A.W. Facilitation Inc. Hampton 682517 2015 05 06

682518 NB INC. Miramichi 682518 2015 05 06

682521 NB INC. Miscou 682521 2015 05 06

682524 NB INC. Cocagne 682524 2015 05 06

ML Project Management Inc. Shediac 682526 2015 05 06

OPL Investments Inc. Saint John 682527 2015 05 06

LANCASTER COMPUTER & CELLPHONE Ltd. Saint John 682530 2015 05 06

682531 N.B. Inc. Hillsborough 682531 2015 05 06

682533 N.B. Inc. Saint John 682533 2015 05 06

682534 N.B. Inc. Saint John 682534 2015 05 06

682535 N.B. LTD. Saint John 682535 2015 05 06

CHALEUR COLLEGE INC. Bathurst 682543 2015 05 07

R2C Floor Care Inc. Dieppe 682548 2015 05 07

682549 NB LTD. Napan 682549 2015 05 07

682555 NB Ltd. Quispamsis 682555 2015 05 07

Concrete Concepts Ltd. Burton 682560 2015 05 07

CHANTILLY LACE EVENTS LTD. Fredericton 682561 2015 05 07

Duke Holdings Inc. Saint John 682562 2015 05 07

682564 NB Ltée Tracadie-Sheila 682564 2015 05 07

682565 NB Inc. Caraquet 682565 2015 05 07

CHALEUR BREEZES BEEF LTD. Belledune 682571 2015 05 07

Premier Concrete Designs Inc. Moncton 682572 2015 05 07

Marshall Hill Builders Inc. Sussex Corner 682573 2015 05 07

_____________________________________________________

ExamOne Canada, Inc. Fredericton Ontario 682439 2015 04 30

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 644 Gazette royale — 27 mai 2015

RIVERVIEW TRUCK REPAIR LTD. 039479 2015 05 01

ORTHOPAEDICS PLUS LTD. 500340 2015 05 06

CONSOLIDATED SERVICES LTD. 509031 2015 05 07

C. MacLean Heating Company Ltd. 617056 2015 05 06

635362 N.B. Ltd. 635362 2015 04 30

Drs Robert Poirier et Danielle Comeau Corp. Prof. Inc. 635566 2015 05 05

C & K MacLean Holdings Inc. 643834 2015 05 06

COASTAL MACHINE WORKS INC. 668127 2015 05 07

T. R. Caravan Enterprises Inc. 674704 2015 05 01

675372 N.B. Inc. 675372 2015 05 06

CHAISSON MANAGEMENT LTD. 678143 2015 05 07

M.E.L. Trucking Inc. 682273 2015 05 06

_____________________________________________________

Breau’s Salvage Ltd. BREAU DISPOSAL LTD. 037845 2015 05 06

501108 NB Ltd. MARIFLEX LIMITED 501108 2015 05 01

506491 N.B. Inc. MOIR INSURANCE INC. 506491 2015 05 01

627701 NB Inc. DANIEL LEVESQUE & JOHANNE RIOUXLIMITÉE

627701 2015 05 01

650472 NB Inc. GROUPE CULINAIRE ROBERT H. NOEL INC. 650472 2015 05 06

BLUTIP POWER TECHNOLOGIES INC. 663447 N.B. Inc. 663447 2015 05 07

Amanda Gilks Coaching Inc. Cana-Group Business Centres Inc. 668084 2015 05 07

671185 N.B. Inc. Sonya Fraser Professional Corporation 671185 2015 05 05

MISCOU FISH PRODUCTS INC. 679180 N.B. Ltd. 679180 2015 05 07

KAYE FARMS LTD 682188 NB INC. 682188 2015 05 05

PrimeWebsite Inc. PrimusWebsite inc. 682191 2015 04 29

DÉVELOPPEMENT MALLET LTÉE 680025 NB Ltée 682286 2015 05 01

667658 N.B. Ltd. 682178 N.B. Ltd. 682429 2015 05 01

RESTAURANT CHEZ RAYMOND LTEE 507404 N.B. LTEE/LTD. 682431 2015 05 01

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 645 Gazette royale — 27 mai 2015

BJP FISHERIES INC. PECHERIE A. F. NO 1 LTEE 682436 2015 05 06

Fagan Brothers Contractors (1996) Ltd. 682297 NB Ltd. 682512 2015 05 04

_____________________________________________________

S & A Holding (2015) Ltd. S & A HOLDING LTD.CITY AMUSEMENT INC.

Saint John 682209 2015 05 01

VERGER BELLIVEAU ORCHARD LTD. VERGER BELLIVEAU ORCHARD LTD.FERME BOURGEOIS FARM INC.

Memramcook 682252 2015 05 01

680025 NB Ltée DÉVELOPPEMENT MALLET LTÉE680025 NB Ltée

Shippagan 682286 2015 05 01

682178 N.B. Ltd. 667658 N.B. Ltd.682178 N.B. Ltd.

Long Reach 682429 2015 05 01

507404 N.B. LTEE/LTD. 507404 N.B. LTEE/LTD.RESTAURANT CHEZ RAYMOND LTEE

Neguac 682431 2015 05 01

Nuttall Construction (1994) Ltd. EXPLORE PLUS DUCT CLEANING LTD.Nuttall Construction (1994) Ltd.

Riverview 682434 2015 04 30

FRANK BROWNE FARMS INC. Browne Potato Inc.FRANK BROWNE FARMS INC.

Grand-Sault / Grand Falls

682445 2015 04 30

PIÈCES D’AUTO SAVOIE LANGLOISLTÉE

ENTREPRISE GAGNON LTEEPièces d’Auto Saint-Quentin LtéePIÈCES D’AUTO SAVOIE LANGLOIS LTÉE

Saint-Quentin 682450 2015 05 01

J.T. TONER & SONS LTD. J.T. TONER & SONS LTD.J.T. TONER & SONS (2012) LTD.

Grand-Sault /Grand Falls

682456 2015 04 30

682297 NB Ltd. FAGAN BROTHERS CONTRACTORS (1996) LTD.682297 NB Ltd.

Scoudouc 682512 2015 05 04

_____________________________________________________

COMANCON LTD. Saint John 004045 2015 04 30

DR. R. C. MACDONALD PROFESSIONAL CORPORATION Fredericton 042635 2015 04 28

508204 NB Inc. Rogersville 508204 2015 04 27

MARITECH TRUCKING LTD. L’Etete 601452 2015 04 30

GREENLAND HOLDINGS LTD. Fredericton 609229 2015 04 27

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 646 Gazette royale — 27 mai 2015

611737 N.B. Inc. Grand Manan 611737 2015 05 06

DCS Laboratory Services Limited Saint John 612532 2015 04 28

Lott Technology Enterprise Inc. Saint John 644684 2015 05 06

ARP Antioxidant Rich Potatoes Ltd. Drummond 654270 2015 05 06

Solstice Soap Co. Inc. Fredericton 655742 2015 04 28

Wisdom Partners Inc. Quispamsis 657594 2015 05 07

668277 NB Ltd. Haut-Paquetville 668277 2015 05 05

Pham Mechanical & Electrical Inc. Moncton 671966 2015 05 07

GRACE MARINE SERVING AND TRADING COMPANY LTD. Fredericton 673429 2015 04 28

_____________________________________________________

Moreau & Fils Entreprises Ltée 009665 2015 04 27

L. H. GOULD HOLDINGS LTD. 031201 2015 05 05

DR. JODY M. WHEELER PROFESSIONAL CORPORATION 512150 2015 05 01

RIDGEVIEW HOLDINGS LTD. 516132 2015 04 28

618326 NB LTÉE 618326 2015 05 01

ON TOUR CONCERTS INC. 629864 2015 05 01

CELACA RESOURCES INC. 630833 2015 04 28

Waves To Avalanche Inc 635170 2015 05 06

Lloyds of Bread 1232 Ltd. 639446 2015 05 07

AJP Media Holdings Inc. 646119 2015 05 06

East Coast Home Inspection Ltd. 651340 2015 05 01

MDM Construction & Demolition Ltd. 654420 2015 05 06

658880 NB Ltd. 658880 2015 04 29

Jesse Brun Mortgage Specialist Inc. 661481 2015 04 27

Les Construction Marcel & Michel 2012 Ltd. 663164 2015 04 29

Youn’s Enterprise Ltd. 663192 2015 05 06

Century Siding & Roofing Inc. 665264 2015 04 30

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 647 Gazette royale — 27 mai 2015

La Caisse centrale Desjardins du Québec Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Moncton

682084 2015 04 28

9263683 Canada Inc. Canada Normand MartinSaint-Jacques

682357 2015 05 05

Wellspring Acceptance Corporation Canada McInnes Cooper CSD Services Inc.Fredericton

682367 2015 04 27

MOTHER PARKER’S TEA & COFFEE INC.

Ontario Teresa SmithForest Glen

682430 2015 04 30

MATRIX SOLUTIONS INC. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

682440 2015 05 01

BONTE FOODS LTD. Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

Richard E. DeBowMoncton

682471 2015 05 04

I.M.W. INDUSTRIES LTD. Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

682475 2015 05 04

P.F. COLLINS CUSTOMS BROKER LIMITED

Terre-Neuve et Labrador/ Newfoundland and Labrador

Saint John 682476 2015 05 04

_____________________________________________________

GLENCORE TECHNOLOGY CANADA LTD. XSTRATA TECHNOLOGY CANADA LTD. 639986 2015 05 01

eBay Enterprise, Inc. GSI Commerce Solutions, Inc. 646671 2015 04 27

DucatFlow Inc. 8836833 Canada Inc. 676000 2015 05 04

Dritan Enterprise Business Marketing Corp. Dritan Capital ltd. 677008 2015 04 27

SAINT-GOBAIN CANADA INC. Saint-Gobain Abrasives Canada Inc. 680490 2015 04 29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 648 Gazette royale — 27 mai 2015

Guardian Building Products Distribution Canada, Inc.

Canada Peter Klohn 076632 2015 05 04 2015 08 01

SKY INVESTMENT COUNSEL INC. Canada Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.

615602 2015 05 04 2015 08 01

Q1 Labs, Inc. Delaware John C. Gillis 624123 2015 05 04 2015 08 01

WALTON YELLOWHEAD DEVELOPMENT CORPORATION

Alberta Michael A. Gillis 659561 2015 05 04 2015 08 01

NEXTERA ENERGY CANADA, ULC

Alberta Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.

674871 2015 05 04 2015 08 01

_____________________________________________________

MXD Group, Inc. Californie / California

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

077446 2015 05 03

Deluxe Toronto Ltd. Ontario Len HoytFredericton

626911 2015 05 03

SOLUTIONS DE FREINS CANADA, INC./BRAKE SOLUTIONS CANADA, INC.

Québec / Quebec Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

638929 2015 05 03

Industrielle Alliance, Services professionnels inc./Industrial Alliance Professional Services Inc.

Canada Steven D. ChristieFredericton

648349 2015 05 03

SHFL entertainment, Inc. Minnesota Franklin O. LegerSaint John

648494 2015 05 03

7308051 Canada Ltd. Canada Walter D. VailFredericton

649317 2015 05 03

WALLS APPAREL CANADA, INC. Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey Corporate Services(NB) Inc.Saint John

650594 2015 05 03

Themis Solutions Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

660627 2015 05 03

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex-traprovinciales suivantes :

Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given, under the Business CorporationsAct, of the cancellation of the registration of the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis d’annulation a été émis aux corporations extraprovincialessuivantes :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 649 Gazette royale — 27 mai 2015

DR VIRGINIE GAUVREAU M.D. INC. Québec / Quebec Virginie GauvreauDalhousie Junction

673805 2015 05 03

_____________________________________________________

ALPHA TECHNOLOGIES LTD. Alpha Technologies Ltd. Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

682424 2015 04 30

Groupe ISN Canada Inc.ISN Canada Group Inc.

ISN CANADA GROUP INC./GROUPE ISNCANADA INC.

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

682474 2015 05 04

THE UNION CLUB COMPANY 016516 2015 05 07

BELLEISLE WATERSHED COALITION INC. 667907 2015 05 05

CANCARE N.B. FOUNDATION INC. 670174 2015 05 04

THE OWENS FAMILY FOUNDATION INC. 673938 2015 05 05

_____________________________________________________

Théâtre Alacenne Inc. 656179 2015 05 01

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 650 Gazette royale — 27 mai 2015

Beresford Plowing THE CARPET RANCH LTD. - LA GRANGE À TAPIS LTÉE

Beresford 681820 2015 04 14

Desjardins Canadian Financial La Caisse centrale Desjardins du Québec

Moncton 682085 2015 04 28

E J COURIER & DELIVERY SERVICE

Terrance Benjamin Paul Oromocto 682197 2015 04 28

Parking Lines Plus by Dave David Robinson Fredericton 682225 2015 04 28

AffGlo GLOBAL CREDIT & COLLECTION INC.

St. Stephen 682253 2015 04 30

Roche Diagnostics, a Division of Hoffmann-La Roche Limited

HOFFMANN-LA ROCHE LIMITEDHOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE

Saint John 682341 2015 04 27

Thunder N Lightning Motorsports Gerald Robert Young McAdam 682351 2015 04 27

Garderie des p’tits minis Michelle Hébert Pointe-Canot 682352 2015 04 27

Cynsational Living, Health & Wellness Cynthia Killam River Glade 682356 2015 04 27

Wellspring Financial Wellspring Acceptance Corporation

Fredericton 682368 2015 04 27

Acadian Rapee Acadien TERRY ROY’S BERRY FARM LTD.

Sainte-Marie-de-Kent 682372 2015 04 28

Acadian Poutine Acadien TERRY ROY’S BERRY FARM LTD.

Sainte-Marie-de-Kent 682373 2015 04 28

COBBLESTONE LANDSCAPING Rob McInnis Quispamsis 682411 2015 04 29

Custom Solution Motorcycle Repairs

Stéphane Fournier Petit-Rocher-Ouest 682412 2015 05 01

Bartels Car Wash A & S Bartels Ltd. Minto 682415 2015 04 29

Bartels Pool Supply A & S Bartels Ltd. Minto 682420 2015 04 29

Witherell Consulting Nancy Witherell Fredericton 682432 2015 05 01

MCyr Media Maurice Cyr Dieppe 682448 2015 05 01

For the Love of You Coaching Rachel Basque Lakeville-Westmorland 682458 2015 05 01

Bedard Food Equipment SUMMERTIME INDUSTRIES (N.B.) Ltd.

Saint John 682459 2015 05 01

Twin Birch Lodge Carole Goguen Shemogue 682462 2015 05 01

Proactive Therapy Services Algalore Professional Corporation

Fredericton 682464 2015 05 01

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 651 Gazette royale — 27 mai 2015

STRICKLY FIRST AID INSTRUCTION

Rob Strickland Burton 682465 2015 05 01

FUTURE SHINE CLEANING Cory Daniel Pitre Fredericton 682466 2015 05 01

EHPC Excel Hockey Performance Adrien Lemay Moncton 682467 2015 05 01

Cadillac Landscaping Dave Lafrance Florenceville 682469 2015 05 02

PRECISION AUTO CLINIC GIL MACBETH SALES LTD. Moncton 682470 2015 05 04

The Pridham Group Mark Pridham Saint John 682477 2015 05 04

J D GUIMOND SECURITY Josh Guimond Miramichi Bay 682479 2015 05 04

Jenni’s Take-Out Jennilyn Messer McAdam 682481 2015 05 04

T & J Whitening Tina Agnew Sisson Ridge 682485 2015 05 04

Goodine Law Jonathan Goodine Woodstock 682488 2015 05 04

five cent guitars James McLean Moncton 682490 2015 05 05

FERME P. BOURGOIN ELEVAGE DE CERFS DE VIRGINIE

Pierre Bourgoin Saint-Quentin 682493 2015 05 05

GREENFIELD VAPE Teagan Kennedy Greenfield 682496 2015 05 05

JAGWIRE INTERACTIVE Jack Dow Fredericton 682497 2015 05 05

FRIENDLY FRED NEWS Joel Thompson Fredericton 682499 2015 05 05

GRAND FALLS HYUNDAI 627701 NB Inc. Grand-Sault / Grand Falls 682504 2015 05 05

J.K. Beers Transportation Services

Johnson Beers Sussex 682511 2015 05 05

PIÈCES D’AUTO SAINT-QUENTIN PIÈCES D’AUTO SAVOIELANGLOIS LTÉE

Saint-Quentin 682515 2015 05 06

ENTREPRISE GAGNON PIÈCES D’AUTO SAVOIELANGLOIS LTÉE

Saint-Quentin 682516 2015 05 06

Banh Mignon Food Truck Ivy Lam Moncton 682522 2015 05 06

VAI (value add forest products) Tim Dunn Upper Kingsclear 682523 2015 05 06

CLARK’S AFTER SCHOOL ADVENTURES

Karen Clark Miramichi 682525 2015 05 06

Locym Concrete Luc LeBlanc Cap-Pelé 682528 2015 05 06

A. Fern’s Quality Construction Fernand Allain Sainte-Anne-de-Kent 682529 2015 05 06

LITTLE’S JUST BAKED GLUTEN FREE

Michelle Lyn Swan Harvey 682532 2015 05 06

Garage Petite-Lamèque Eloi Gauvin Petite-Lamèque 682536 2015 05 06

Oiled Creations by Nancy GL Nancy Gray Leger Miramichi 682537 2015 05 06

SamtalPartners Research & Consulting

Ross Leadbetter New Maryland 682538 2015 05 07

SERGE AND CO TRANSPORTATION

Sergey Godik Fredericton 682550 2015 05 07

HIGH SEA’S CONVENIENCE Kitt Greenlaw Grand Manan 682551 2015 05 07

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 652 Gazette royale — 27 mai 2015

TURQUOISE COAST TOURS AND TRAVEL

Erkan Demir Saint Andrews 682575 2015 05 07

_____________________________________________________

TRIPLE CROWN TRANSPORT Midland Transport LimitedTransport Midland Limitée

Dieppe 323793 2015 05 06

“ASSOMPTION VIE” “ASSUMPTION LIFE”

ASSOMPTION COMPAGNIEMUTUELLE D’ASSURANCE –VIE ASSUMPTION MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY

Moncton 328235 2015 04 29

FUNDY NURSING HOME FUNDY HEALTH CENTRE INC. Blacks Harbour 332961 2015 04 28

CASE CREDIT CNH INDUSTRIAL CAPITALCANADA LTD.CNH INDUSTRIEL CAPITALCANADA LTEE

Saint John 333942 2015 05 04

HEALTH HORIZONS Ruth Fraser Quispamsis 334144 2015 05 05

PLC Animal Hospital France Vienneau Miramichi 350000 2015 05 04

Mingler’s Restaurant ATTIKA PIZZA LTD. Oromocto 604051 2015 05 05

IRVING ENERGY SERVICES/SERVICES D’ENERGIE IRVING

IRVING ENERGY SERVICESLIMITEDSERVICES D’ENERGIE IRVINGLIMITEE

Saint John 615256 2015 05 06

Castle Apartments Leslie Somers Sillikers 617240 2015 05 02

THE CRAZY FROG Cheryl Hawkes Quispamsis 617313 2015 04 28

TOTAL CONCEPTS (2005) HAIR SALON

Anita Fox Nackawic 617316 2015 04 28

T Daigle Repair Works Therese Daigle Saint-Thomas-de-Kent 617375 2015 04 30

Taylor’s Autobody and General Repair

Martin Taylor Second North River 618390 2015 05 07

CRAFTY CORNER CHILDCARE CENTRE

Mark ThompsonBruce BullaBrenda KilfoilTracey McIntoshBruce BullaSarah Taylor

Bristol 618855 2015 04 29

POLYONE DISTRIBUTION CANADA

PolyOne Canada Inc. Saint John 618891 2015 05 01

CNH CAPITAL CNH INDUSTRIAL CAPITALCANADA LTD.CNH INDUSTRIEL CAPITALCANADA LTEE

Saint John 618956 2015 05 04

R.E. & J.E. FRIARS TRANSPORT RST Industries LimitedLes Industries RST Limitée

Saint John 619331 2015 05 06

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 653 Gazette royale — 27 mai 2015

KV STYLE Brunswick News IncNouvelles Brunswick Inc.

Sussex 619445 2015 05 01

Rodd Miramichi River Lodge and Conference Centre

RODD MANAGEMENT LIMITED

Saint John 619576 2015 05 01

The Equity Club RODD MANAGEMENT LIMITED

Saint John 619577 2015 05 01

DAVE’S REFINISHING SERVICES David McCain Moncton 647506 2015 04 27

Signal Enterprises / Entreprises Signal

Charles McAllan Fredericton 649292 2015 05 01

True North Greyhounds Erin BowesNeal MacLeanJaime Bowes

Riverview 649375 2015 04 29

Peak New Construction & Renovations

KRAMARA ENTERPRISES INC. Fredericton 649501 2015 04 30

Pamela Stephenson Physio In Motion

Pamela Stephenson Moncton 649556 2015 05 06

CEDAR HILLS LANDSCAPING ERB Builders Ltd. Saint John 649622 2015 05 05

L’APPRENTI ATELIER DE VIN ET CUISINE

Robert Noël Caraquet 649640 2015 05 06

Décapage Levesque Woodworking Etienne Levesque Saint-Arthur 649663 2015 04 30

Exit Realty Charlotte County Guy R. Day & Son Limited St. Stephen 649695 2015 04 28

Aspen Bed & Breakfast Leona Geldart Moncton 649804 2015 04 30

Wild Tile Custom Installations Sean Rowan Killarney Road 649898 2015 05 02

VISTA INTERIORS AND CONSTRUCTION

Lee Kennedy Cocagne 649926 2015 04 28

Joe Colter Electric Joseph Colter Fredericton 650033 2015 04 28

Western Financial Group Insurance Solutions

Western Financial Group(Network) Inc.

Saint John 650122 2015 04 27

BG COURIER William Gaines Kingston 650147 2015 05 04

Earthworks Garden Design Alexander Brennan Fredericton 650154 2015 05 04

DW Decor Danny Wilson Saint John 650156 2015 05 05

Rail’s Cleaning Services Marlene Ann Rail Dieppe 650750 2015 04 28

MIKE BELL CONSULTING Michael Bell Rothesay 650866 2015 05 01

DISTRIBUTION P.D.G. Groupe ISN Canada IncISN Canada Group Inc.

Saint John 675092 2015 05 04

LUBEQUIP Groupe ISN Canada IncISN Canada Group Inc.

Saint John 675093 2015 05 04

INSTALLATION MULTI-MÉCANIQUE

Groupe ISN Canada IncISN Canada Group Inc.

Saint John 675094 2015 05 04

LES ÉQUIPEMENTS DE GARAGE DENIS

Groupe ISN Canada IncISN Canada Group Inc.

Saint John 675095 2015 05 04

_____________________________________________________

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 654 Gazette royale — 27 mai 2015

E J COURIER & DELIVERY SERVICE Lincoln 334412 2015 04 28

PIZZA HUT CANADA Saint John 349606 2015 05 01

KFC-CANADA Saint John 349607 2015 05 01

TACO BELL OF CANADA Saint John 349608 2015 05 01

Taco Bell Saint John 610426 2015 05 01

Kentucky Fried Chicken Saint John 610427 2015 05 01

Kentucky Fried Chicken - Canada Saint John 610428 2015 05 01

KFC Saint John 610429 2015 05 01

Pizza Hut Saint John 610430 2015 05 01

Proactive Therapy Services Keswick Ridge 640633 2015 04 30

TWIN BIRCH LODGE Shemogue 649059 2015 05 01

Cranberry Island Healing Centre Harvey 678368 2015 05 05

Appalachian Chaga DSL de Drummond /LSD of Drummond

679745 2015 05 05

Atlantic Land Drafting and Consultants Waasis 681711 2015 05 04

RVCS-RECREATIONAL VEHICLE CONSIGNMENT SERVICES Lincoln 682243 2015 05 01

LUTES LOGGING Monteagle 682251 2015 05 05

_____________________________________________________

HRG North America Franklin O. LegerSaint John

624956 2015 05 05

BTI Canada Franklin O. LegerSaint John

626519 2015 05 05

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of agent forservice has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

ReferenceNumber Date

Agent and Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 655 Gazette royale — 27 mai 2015

JoLi’s Quilting Joanne GirouardLinda Girouard

Moncton 681823 2015 04 01

E.M.Fit Plus Fitness & Nutrition Mylène VioletteEmilie Bérubé

Saint-Joseph-de-Madawaska 681857 2015 04 29

The Crowded House Café Andrew GliddenKatie-Lynn Mansvelt

Saint John 682438 2015 04 30

Cranberry Island Healing Centre Paul A. SmithKaren Jean Smith

Harvey 682507 2015 05 05

_____________________________________________________

Thunder N Lightning Motorsports McAdam 667259 2015 04 27

Access Justice Moncton Limited Partnership

Access JusticeMoncton, GP Ltd.

Saint John 642335 2015 05 01

_____________________________________________________

Summit Acceptance Limited Partnership

Saint John Alberta Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

682473 2015 05 04

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 656 Gazette royale — 27 mai 2015

DHL No. 32 Limited Partnership

Delta Hotels No. 32 Limited Partnership

Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

604519 2015 05 01

DHL Hotels Limited Partnership

Delta Hotels Limited Partnership

Manitoba Willard JenkinsSaint John

680569 2015 04 27

_____________________________________________________

TFI TRANSPORT 8 L.P. Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

656935 2015 05 05

NORREP SHORT DURATION 2014 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP

Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

675149 2015 04 29

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,which includes a name change, has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale, contenantune nouvelle raison sociale, a été déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Previous Name Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

NOTICE OF PUBLIC HEARINGNOTICE is given that a public hearing of the Municipal CapitalBorrowing Board will be held - Monday June 8, 2015, at2:00 p.m., Tower Boardroom, 3rd Floor, Marysville Place,Fredericton, New Brunswick, to hear the following applicationsfor authorization to borrow money for a capital expense:

TIME MUNICIPALITY PURPOSE AMOUNT

2:05 p.m. Riverview Transportation ServicesOperations Centre $16,575,000

2:15 p.m. Kedgwick Protective ServicesGenerator $40,000

2:25 p.m. Riverside-Albert Environmental Health Services (General)1 ton truck with plow $65,000

2:35 p.m. Saint-Louis de Kent Transportation ServicesTruck $40,000

Municipal CapitalBorrowing Act

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUESACHEZ que la Commission des emprunts de capitaux par lesmunicipalités tiendra une audience publique - lundi le 8 juin2015, à 14 h, salle de conférence de la tour, 3e étage, PlaceMarysville, Fredericton (Nouveau-Brunswick) pour entendreles demandes suivantes visant l’autorisation d’emprunter desfonds en vue de dépenses en capital :

HEURE MUNICIPALITÉ BUT MONTANT

14 h 05 Riverview Services relatifs aux transportsCentre des opérations 16 575 000 $

14 h 15 Kedgwick Services de protectionGénératrice 40 000 $

14 h 25 Riverside-Albert Services d’hygiène environnementale (général)Camion d’une tonne équipé d’une lame 65 000 $

14 h 35 Saint-Louis de Kent Services relatifs aux transportsCamion 40 000 $

Loi sur les emprunts decapitaux par les municipalités

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 657 Gazette royale — 27 mai 2015

Toute objection à ces demandes peut être présentée à la Com-mission par écrit ou de vive voix au moment de l’audience. Se-crétaire de la Commission des emprunts de capitaux par les mu-nicipalités, Place Marysville, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1, téléphone : 453-2154, télécopieur :453-7128

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation gestuelle ou d’un dis-positif technique pour malentendants (système FM), veuillez téléphonerau Saint John Deaf & Hard of Hearing Services au 506-634-8037(ATS).

14 h 45 Grande-Anse Services récréatifs et culturelsEnseigne lumineuse 40 000 $Services relatifs aux transportsChasse-neige 250 000 $

TOTAL 290 000 $

14 h 55 Shediac Services relatifs aux transportsConstruction de routes - rue Main 1 100 000 $Services d’hygiène environnementale (Utilité)Renouvellement du système d’eau - rue Main 400 000 $

TOTAL 1 500 000 $

15 h 05 RSC #11 Services d’hygiène environnementale (général)Chargeur 36 000 $Chariot élévateur 38 000 $Excavateur 200 000 $

TOTAL 274 000 $

15 h 15 Memramcook Services de protectionCamion d’incendie 350 000 $

15 h 25 Saint Andrews Services d’hygiène environnementale (Utilité)Améliorations du système d’eau et d’égouts - rue Charles (modifié) 300 000 $

15 h 35 Grand Tracadie-Sheila

Services d’administration généraleImmeuble à bureaux 750 000 $Services récréatifs et culturelsCompresseur 10 000 $Réfections des terrains de tennis 35 000 $Aménagement d’un parc pour planches à roulettes 168 000 $Rénovation de l’aréna 409 000 $Services relatifs aux transportsRéfections de trottoirs - rue Principale 50 000 $Débroussailleuse 60 000 $Tracteur 65 000 $Réfections de routes - rue Faudel 89 000 $Creusage de la voie navigable - Val-Comeau 150 000 $

TOTAL 1 786 000 $

15 h 45 Le Goulet Services relatifs aux transportsAméliorations de routes 57 000 $Améliorations des égouts pluviaux et système de collecte 60 000 $

TOTAL 117 000 $

Objections to these applications may be filed in writing or pre-sented orally to the Board at the hearing. Secretary, MunicipalCapital Borrowing Board, Marysville Place, P.O. Box 6000,Fredericton, New Brunswick E3B 5H1, TEL: 453-2154, FAX:453-7128

If you require sign language interpretation or an assistive listeningdevice or FM system, please contact the Saint John Deaf & Hard ofHearing Services (TTY) 506-634-8037.

2:45 p.m. Grande-Anse Recreation & Cultural ServicesIlluminated sign $40,000Transportation ServicesSnowplow $250,000

TOTAL $290,000

2:55 p.m. Shediac Transportation ServicesRoad reconstruction - Main Street $1,100,000Environmental Health Services (Utility)Water system renewal - Main Street $400,000

TOTAL $1,500,000

3:05 p.m. RSC #11 Environmental Health Services (General)Skidsteer $36,000Forklift $38,000Excavator $200,000

TOTAL $274,000

3:15 p.m. Memramcook Protective ServicesFire truck $350,000

3:25 p.m. Saint Andrews Environmental Health Services (Utility)Water and sewer renewal - Charles Street (amended) $300,000

3:35 p.m. Grand Tracadie-Sheila

General Government ServicesOffice building $750,000Recreation & Cultural ServicesCompressor $10,000Tennis courts reconstruction $35,000Skateboard park development $168,000Arena renovations $409,000Transportation ServicesSidewalk reconstruction - Principale Street $50,000Brush cutter $60,000Tractor $65,000Road reconstruction - Faudel Street $89,000Dredging waterway - Val-Comeau $150,000

TOTAL $1,786,000

3:45 p.m. Le Goulet Transportation ServicesRoad reconstruction $57,000Storm sewers and collection system upgrades $60,000

TOTAL $117,000

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 658 Gazette royale — 27 mai 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Joseph Michel Noel and Marie Francine Noel, originalMortgagors and owners of the equity of redemption; and to NewBrunswick Legal Aid Services Commission, lien claimant; andto all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of themortgage and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, asamended. Freehold property situate at 1262 Daniel Drive,Bathurst, in the County of Gloucester and Province of NewBrunswick, and being identified as PID 20161816.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at theBathurst Court House, 254 St. Patrick Street, Bathurst, N.B. onThursday, June 4, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time.See advertisement of Notice of Mortgage Sale in The NorthernLight dated May 5, May 12, May 19, and May 26, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

SERGE ST-ONGE and DAISY CAROL BELLEFLEUR,owners and Mortgagors of the land having the civic address of6 Grondin Street, in Saint-Jacques, in the County ofMadawaska and Province of New Brunswick; CAISSE POPU-LAIRE MADAWASKA LTÉE, first Mortgagee; NEWBRUNSWICK LEGAL AID SERVICES COMMISSION,holder of two certificates of lien; and TO ALL OTHERSWHOM IT MAY CONCERN.

Land having the civic address of 6 Grondin Street, in Saint-Jacques, in the County of Madawaska and Province of NewBrunswick, and bearing PID 35041334.Notice of Sale given by the above holder of the first mortgage.

Sale on June 15, 2015, at 11:00 a.m., at Carrefour Assomption,121 Church Street, in Edmundston, New Brunswick. See adver-tisement in the May 16, 23, and 30, and June 6, 2015, editionsof the weekly Le Madawaska.DATED at Edmundston, New Brunswick, this 5th day of May,2015.

Gary J. McLaughlin, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solici-tors and Agents for Caisse populaire Madawaska Ltée

________________

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Joseph Michel Noel et Marie Francine Noel, dé-biteurs hypothécaires originaires et propriétaires du droit de ra-chat; Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, demanderesse de privilège; et tout autre intéressééventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acted’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.Biens en tenure libre situés au 1262, promenade Daniel, àBathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 20161816.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de la première hypothèque. Lavente aura lieu le jeudi 4 juin 2015, à 11 h, heure locale, au pa-lais de justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 5, 12, 19 et 26 mai 2015 du journal The Northern Light.

R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

SERGE ST-ONGE et DAISY CAROL BELLEFLEUR, pro-priétaires du bien-fonds ayant l’adresse civique 6, rue Grondin,à Saint-Jacques, dans le comté de Madawaska et province duNouveau-Brunswick, à titre de débiteurs hypothécaires;CAISSE POPULAIRE MADAWASKA LTÉE, à titre decréancière hypothécaire d’une hypothèque de premier rang;COMMISSION DES SERVICES D’AIDE JURIDIQUEDU NOUVEAU-BRUNSWICK, détentrice de deux certificatsde privilège; et À TOUS AUTRES INTÉRESSÉS ÉVEN-TUELS.Bien-fonds ayant l’adresse civique 6, rue Grondin, à Saint-Jacques, dans le comté de Madawaska et province du Nouveau-Brunswick et connue sous le NID 35041334.Avis de vente donné par le titulaire susnommé de la premièreHypothèque.Vente le 15 juin 2015 à 11 h, au Carrefour Assomption,121, rue de l’Église, Edmundston (N.-B.). Voir l’annonce paruedans le journal hebdomadaire Le Madawaska, éditions des16 mai, 23 mai, 30 mai et 6 juin 2015.FAIT à Edmundston (Nouveau-Brunswick), le 5e jour de mai2015.

Gary J. McLaughlin, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin,avocats et agents pour Caisse populaire Madawaska Ltée

________________

Avis de vente

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 659 Gazette royale — 27 mai 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Walter Robert Charles Turner, original Mortgagor; and to allothers whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at527 Summer Street West, Saint John, New Brunswick, the samelot conveyed to Walter Robert Charles Turner by Transfer reg-istered in the Saint John Registry Office on November 14, 2000,in Book 2154, Pages 12-23, as document number 1152573.

Notice of Sale given by Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the Saint John Provincial Building located at10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 11th day ofJune, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertise-ment of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated May 14,May 20, May 27 and June 3, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Nova Scotia, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

TO: ALBERT ELLSWORTH WEAGLE and BARRYWAYNE WEAGLE, Mortgagors;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CON-CERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 3 Kimberlee Lane, Burton, SunburyCounty, Province of New Brunswick and known as Parcel Iden-tifier Number (PID) 60052156.Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The sale is scheduled for Thursday, June 18, 2015, at11:00 a.m., at the Fredericton Court House, 427 Queen Street,Fredericton, New Brunswick.See advertisements in The Daily Gleaner in the issues of May20, May 27, June 3, and June 10, 2015.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for theToronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, LegislativeServices, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Royal GazetteCoordinator may refuse to publish a document if any part of itis illegible, and may delay publication of any document for ad-ministrative reasons.

Notice to Advertisers

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Walter Robert Charles Turner, débiteur hypothé-caire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au527, rue Summer Ouest, à Saint John (Nouveau-Brunswick),correspondant au même lot ayant été transféré à Walter RobertCharles Turner et enregistré au bureau de l’enregistrement ducomté de Saint John le 14 novembre 2000, sous le numéro1152573, aux pages 12 à 23 du registre 2154.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 11 juin 2015, à 11 h,heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, 10, place Peel,Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 14, 20 et 27 mai et du 3 juin 2015 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400,644, rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

DESTINATAIRES : ALBERT ELLSWORTH WEAGLEet BARRY WAYNE WEAGLE, débiteurs hypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 3, allée Kimberlee,à Burton, comté de Sunbury, province du Nouveau-Brunswick,et dont le numéro d’identification parcellaire est 60052156.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 18 juin 2015, à 11 h, au palais de jus-tice de Fredericton, 427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 20 et 27 mai et des3 et 10 juin 2015 du journal The Daily Gleaner.

Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avo-cats de LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TDCanada Trust)

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.

Avis aux annonceurs

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 660 Gazette royale — 27 mai 2015

Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 661 Gazette royale — 27 mai 2015

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Legislative ServicesOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-8372E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the Commissionaire.

Statutory Orders and Regulations Part II

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables deport et de manutention.

Services législatifsCabinet du procureur général

Place Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-8372Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

Ordonnances statutaires et Règlements Partie II

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 662 Gazette royale — 27 mai 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-12

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-12

pris en vertu de la

MUNICIPALITIES ACT(O.C. 2015-98)

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS(D.C. 2015-98)

Filed May 15, 2015 Déposé le 15 mai 2015

1 Section 34 of New Brunswick Regulation 85-6 un-der the Municipalities Act is repealed and the followingis substituted:

1 L’article 34 du Règlement du Nouveau-Brunswick85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités estabrogé et remplacé par ce qui suit :

34(1) The village called Village of Atholville is con-tinued.

34(1) Est maintenu le village appelé Villaged’Atholville.

34(2) The local service district of St. Arthur, the localservice district of Val D’Amours, a portion of the Vil-lage of Tide Head and a portion of the local service dis-trict of Blair Athol, being areas contiguous to Village ofAtholville, are annexed to Village of Atholville and thenew territorial limits of Village of Atholville are shownon the plan attached as Schedule 34(2).

34(2) Le district de services locaux de St-Arthur, ledistrict de services locaux de Val D’Amours, une partiedu Village de Tide Head et une partie du district de ser-vices locaux de Blair Athol, étant des régions contiguësau Village d’Atholville, sont annexés au Villaged’Atholville et les nouvelles limites territoriales du Vil-lage d’Atholville figurent à l’annexe 34(2) ci-jointe.

34(3) The effective date of the annexation is July 1,2015.

34(3) L’annexion prend effet le 1er juillet 2015.

34(4) Assets acquired and liabilities incurred by theMinister in connection with the provision of services bythe Minister to the areas being annexed to Village ofAtholville before the annexation shall on the annexationbecome assets and liabilities of Village of Atholville.

34(4) Dès l’annexion, les biens acquis et les obliga-tions qu’a engagées le Ministre avant l’annexion relati-vement à sa fourniture de services aux régions annexéesau Village d’Atholville deviennent les biens et obliga-tions du Village d’Atholville.

34(5) Lands and premises vested in the Minister andlocated within the areas being annexed to Village ofAtholville shall be vested in Village of Atholville on an-nexation.

34(5) Dès l’annexion, les terrains et immeubles dévo-lus au Ministre et situés dans les régions annexées auVillage d’Atholville sont dévolus au Villaged’Atholville.

34(6) For the purpose of the first election after annexa-tion,

34(6) En vue de la première élection suivant l’an-nexion,

Page 31: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 663 Gazette royale — 27 mai 2015

(a) the first council shall be composed of a mayorand six councillors,

a) le premier conseil est composé d’un maire et desix conseillers;

(b) there shall be three wards within the territoriallimits as shown on the plan attached as Schedule34(2), consisting of

b) les limites territoriales qui figurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 34(2) sont divisées en troisquartiers :

(i) Ward 1, comprising the former local servicedistrict of St. Arthur,

(i) le quartier 1, comprenant l’ancien district deservices locaux de St-Arthur,

(ii) Ward 2, comprising the former local servicedistrict of Val D’Amours and the former portion ofthe local service district of Blair Athol,

(ii) le quartier 2, comprenant l’ancien district deservices locaux de Val D’Amours et l’anciennepartie du district de services locaux de Blair Athol,

(iii) Ward 3, comprising the former portion of theVillage of Tide Head and the Village of Atholvilleas it was before the coming into force of this sec-tion,

(iii) le quartier 3, comprenant l’ancienne partiedu Village de Tide Head et le Village d’Atholvilletel qu’il était avant l’entrée en vigueur du présentarticle;

(c) the mayor shall be elected at large from withinthe territorial limits of the Village of Atholville asshown on the plan attached as Schedule 34(2),

c) le maire est élu au scrutin général à l’intérieurdes limites territoriales du Village d’Atholville qui fi-gurent sur le plan ci-joint en tant qu’annexe 34(2);

(d) one councillor shall be elected from Ward 1,two councillors shall be elected from Ward 2 andthree councillors shall be elected from Ward 3,

d) un conseiller est élu pour le quartier 1, deux con-seillers sont élus pour le quartier 2 et trois conseillerssont élus pour le quartier 3;

(e) the notice of election shall be published no laterthan May 22, 2015,

e) l’avis d’élection est publié au plus tard le 22 mai2015;

(f) the nomination of candidates shall close at 2 p.m.on June 5, 2015,

f) le dépôt des candidatures est clos à 14 h, le 5 juin2015;

(g) the election shall be held on June 29, 2015, g) l’élection a lieu le 29 juin 2015;

(h) the taking of the oath of office and the firstmeeting shall be held on July 15, 2015, except that,where as a result of the filing of petitions requestingrecounts of votes under section 42 of the MunicipalElections Act, a quorum could not be constituted atthat meeting, the taking of the oath of office and thefirst meeting shall be held within ten days after thecandidates are declared elected by the municipal re-turning officer or judge, as the case may be, undersection 41.1 or 42 of the Municipal Elections Act.

h) la prestation du serment d’entrée en fonction et lapremière réunion du conseil du Village d’Atholvilleont lieu le 15 juillet 2015, mais, si le quorum du con-seil du Village d’Atholville ne peut être constitué à cemoment par suite du dépôt d’une requête présentée envertu de l’article 42 de la Loi sur les élections munici-pales exigeant le recomptage des voix, la prestationdu serment d’entrée en fonction et la première réuniondu conseil ont lieu au plus tard dix jours après que lescandidats ont été déclarés élus par le directeur duscrutin municipal ou un juge, selon le cas, en vertu del’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections munici-pales.

34(7) The inhabitants of the area referred to in subsec-tion (2) continue as Village of Atholville.

34(7) Les habitants de la région mentionnée au para-graphe (2) demeurent des habitants du Villaged’Atholville.

Page 32: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 664 Gazette royale — 27 mai 2015

34(8) Despite any provision of the Act or the Commu-nity Funding Act, after July 1, 2015, the Minister shallpay or credit, as the case may be, to the Village of Athol-ville amounts under the Community Funding Act that areowed to or owed to the credit of the former local servicedistricts of St. Arthur and Val D’Amours.

34(8) Malgré toute disposition de la Loi ou de la Loisur le financement communautaire, après le 1er juillet2015, le Ministre verse ou crédite, selon le cas, au Vil-lage d’Atholville tous montants prévus par la Loi sur lefinancement communautaire qui sont dus à l’ancien dis-trict de services locaux de St-Arthur et à l’ancien districtde services locaux de Val D’Amours.

2 Subsection 112(2) of the Regulation is amended bystriking out “The Boom Property at Old Church Pointis included.”

2 Le paragraphe 112(2) du Règlement est modifié parla suppression de « , en incluant la propriété Boom àOld Church Point ».

3 The Regulation is amended by adding the attachedSchedule 34(2) in numerical order.

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’an-nexe 34(2) ci-jointe dans l’ordre numérique.

4 This Order comes into force on May 15, 2015. 4 Le présent décret entre en vigueur le 15 mai 2015.

Page 33: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 665 Gazette royale — 27 mai 2015

SCHEDULE 34(2) / ANNEXE 34(2)

Page 34: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 666 Gazette royale — 27 mai 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-13

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-13

pris en vertu de la

MUNICIPALITIES ACT(O.C. 2015-99)

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS(D.C. 2015-99)

Filed May 15, 2015 Déposé le 15 mai 2015

1 Section 15 of New Brunswick Regulation 84-168under the Municipalities Act is amended

1 L’article 15 du Règlement du Nouveau-Brunswick84-168 pris en vertu de la Loi sur les municipalités estmodifié

(a) in paragraph (a) by striking out “, Glencoe, St.Arthur and Val D’Amours” and substituting “andGlencoe”;

a) à l’alinéa a), par la suppression de « , Glencoe,St. Arthur et Val D’Amours » et son remplacementpar « et Glencoe »;

(b) in paragraph (b) by striking out “, Blair Atholand Val D’Amours” and substituting “and BlairAthol”;

b) à l’alinéa b), par la suppression de « , BlairAthol et Val D’Amours » et son remplacement par« et Blair Athol »;

(c) by repealing paragraph (d) and substituting thefollowing:

c) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplace-ment par ce qui suit :

(d) that area of Restigouche County known as BlairAthol in the parish of Balmoral that is shown on theattached Schedule 15(d) for fire protection and streetlighting;

d) la région du comté de Restigouche appelée BlairAthol dans la paroisse de Balmoral figurant à l’an-nexe 15d) ci-jointe et fournissant la protection contreles incendies et l’éclairage des rues;

(d) in paragraph (f) by striking out “, Point LaNim and Val D’Amours” and substituting “and PointLa Nim”;

d) à l’alinéa f), par la suppression de « , Point LaNim et Val D’Amours » et son remplacement par« et Point La Nim »;

(e) by repealing paragraph (r); and e) par l’abrogation de l’alinéa r);

(f) by repealing paragraph (v). f) par l’abrogation de l’alinéa v).

2 The Regulation is amended by adding the attachedSchedule 15(d) in numerical order.

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’an-nexe 15d) ci-jointe dans l’ordre numérique.

Page 35: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 667 Gazette royale — 27 mai 2015

3 This Regulation comes into force on July 1, 2015. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet2015.

Page 36: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 668 Gazette royale — 27 mai 2015

SCHEDULE 15(d) / ANNEXE 15d)

Page 37: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 669 Gazette royale — 27 mai 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-14

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-14

pris en vertu de la

ASSESSMENT AND PLANNINGAPPEAL BOARD ACT

(O.C. 2015-100)

LOI SUR LA COMMISSION D’APPEL ENMATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME

(D.C. 2015-100)

Filed May 15, 2015 Déposé le 15 mai 2015

1 Subsection 4(5) of New Brunswick Regulation2001-89 under the Assessment and Planning AppealBoard Act is amended

1 Le paragraphe 4(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-89 pris en vertu de la Loi sur la Com-mission d’appel en matière d’évaluation et d’urba-nisme est modifié

(a) by repealing paragraph (cc); and a) par l’abrogation de l’alinéa cc);

(b) by repealing paragraph (ff). b) par l’abrogation de l’alinéa ff).

2 This Regulation comes into force on July 1, 2015. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet2015.

Page 38: The Royal Gazette / Gazette royale (15/05/27) · The Royal Gazette — May 27, 2015 635 Gazette royale — 27 mai 2015 MAY 7, 2015 2015-94 1. Under subsection 2(1) of the Sheriffs

The Royal Gazette — May 27, 2015 670 Gazette royale — 27 mai 2015

NEW BRUNSWICKREGULATION 2015-15

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2015-15

pris en vertu de la

REGIONAL SERVICE DELIVERY ACT(O.C. 2015-101)

LOI SUR LA PRESTATION DE SERVICESRÉGIONAUX(D.C. 2015-101)

Filed May 15, 2015 Déposé le 15 mai 2015

1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2012-91under the Regional Service Delivery Act is amended inRegion 2 under the heading “Local Service Districts”by striking out

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick2012-91 pris en vertu de la Loi sur la prestation de ser-vices régionaux est modifiée à la région 2 sous la rubri-que « Districts de services locaux », par la suppressionde

St. ArthurSt. Jean Baptiste de RestigoucheVal d’Amours

St-ArthurSaint-Jean-Baptiste-de-RestigoucheVal d’Amours

and substituting the following: et son remplacement par ce qui suit :

St. Jean Baptiste de Restigouche Saint-Jean-Baptiste-de-Restigouche

2 This Regulation comes into force on July 1, 2015. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet2015.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés